SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED

SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01475068
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KIRBY EMMCO LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    FIFTHONE LIMITED24 ene 198024 ene 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    7 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 06 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2012

    Estado de capital el 12 oct 2012

    • Capital: GBP 83,424
    SH01

    legacy

    8 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Jochen Braasch como director el 19 jul 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cese del nombramiento de James Hood como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Nazir Sarkar como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Morris como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 06 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Jochen Braasch como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2009

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Llewellyn Kevan Botha el 02 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Christopher John Morris el 22 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Terence Hood el 22 oct 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2008

    10 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Secretario
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    South AfricanLawyer105560560001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Director
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    United KingdomSouth AfricanLawyer105560560001
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm Holt
    Bristol
    England
    Director
    Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm Holt
    Bristol
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant116701010002
    SARKAR, Nazir
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    England
    Director
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    England
    United KingdomBritishDirector157131040003
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Secretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    BritishFinance Executive83564940010
    DEVON, David John
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    Secretario
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    British7756250002
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Secretario
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    British60270470001
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Secretario
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    British60270470001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    British53858740001
    WHIFFEN, John Christopher
    19 Sylvan Way
    BR4 9HA West Wickham
    Kent
    Secretario
    19 Sylvan Way
    BR4 9HA West Wickham
    Kent
    British12432750001
    BAILES, David Delisle
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Director
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    South AfricanDirector92919610001
    BORONKAY, Ronald M
    8 Highfield Court
    08648 Lawrenceville
    New Jersey
    Usa
    Director
    8 Highfield Court
    08648 Lawrenceville
    New Jersey
    Usa
    AmericanExecutive62203530003
    BRAASCH, Jochen
    Woodfield Road
    Redland
    BS6 6PL Bristol
    Apt Number 15 Chandos
    Director
    Woodfield Road
    Redland
    BS6 6PL Bristol
    Apt Number 15 Chandos
    EnglandGermanEmea Financial Officer153472260001
    CHANDOHA, Walter Sam
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Director
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    AmericanCompany Director62029490001
    CHAPMAN, Robert William Frederick
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Director
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector110216200001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritishFinance Executive83564940010
    CROSBY, William Stuart
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Director
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    AustralianChief Operating Officer108743530001
    DEVON, David John
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    Director
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    BritishChartered Accountant7756250001
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Director
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    UkBritishCompany Director60270470001
    FORDE, Deborah Ann
    16 Edison Gardens
    CO4 4AJ Colchester
    Essex
    Director
    16 Edison Gardens
    CO4 4AJ Colchester
    Essex
    BritishExecutive34427200001
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Director
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant189833420001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChairman53858740001
    JACKSON, Alyster Kendall Thornton
    Kilry
    Sion Hill
    BA1 2UH Bath
    Somerset
    Director
    Kilry
    Sion Hill
    BA1 2UH Bath
    Somerset
    BritishCompany Director620410001
    KYRIACOU, Maria
    30 Rowden Road
    Chingford
    E4 8SD London
    Director
    30 Rowden Road
    Chingford
    E4 8SD London
    BritishCompany Director17339600001
    MILLER, Alexander Byron
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Usa
    Director
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Usa
    AmericanExecutive57588460004
    MORRIS, Christopher John
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Director
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    AustraliaAustralianChief Executive Officer114812600001
    POUNDS, Basil Gregory
    Coppers
    St Albans Gardens
    TW1 8AE Teddington
    Middlesex
    Director
    Coppers
    St Albans Gardens
    TW1 8AE Teddington
    Middlesex
    BritishExecutive36504400001
    POUNDS, Basil Gregory
    Coppers
    St Albans Gardens
    TW1 8AE Teddington
    Middlesex
    Director
    Coppers
    St Albans Gardens
    TW1 8AE Teddington
    Middlesex
    BritishCompany Director36504400001
    SMITH, Jason Leigh
    8 Ridgeway Road
    Long Ashton
    BS41 9EU Bristol
    Director
    8 Ridgeway Road
    Long Ashton
    BS41 9EU Bristol
    AustralianChief Financial Officer122062970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Director
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishChief Executive113777700001

    ¿Tiene SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 sept 2003
    Entregado el 26 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the agent and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Provident Bank
    Transacciones
    • 26 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 02 ago 2000
    Entregado el 22 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) and the secured creditors under or in connection with the credit agreement or otherwise
    Breve descripción
    Please refer to form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Provident Bank
    Transacciones
    • 22 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0