GEOQUEST HOLDINGS LIMITED

GEOQUEST HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGEOQUEST HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01478324
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bishop Fleming
    16 Queen Square
    BS1 4NT Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ECL HOLDINGS LIMITED01 nov 199501 nov 1995
    INTERA INFORMATION TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED04 nov 199104 nov 1991
    E.C.L. HOLDINGS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    BALLHAND LIMITED11 feb 198011 feb 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    2 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Victory House Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9LU United Kingdom el 06 feb 2010

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 dic 2009

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Rebecca Martin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Goldby como director

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    6 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    5 páginasAA

    legacy

    6 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    5 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    5 páginasAA

    legacy

    6 páginas363a

    legacy

    6 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DROY MOORE, Pauline
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    Secretario
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    British138236320002
    DROY MOORE, Pauline
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    Director
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    EnglandBritish138236320002
    SMOKER, Simon
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    Director
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    United KingdomBritish134158640001
    DAVISON, Douglas Stewart
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    Secretario
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    British38662990001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Secretario
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    British32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Secretario
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    ZIMMER, Harold Rudy
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Secretario
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Canadian44656690001
    BULLOCK, Brian Leonard
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Director
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Canadian25257010001
    GOLDBY, Alan John
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    Director
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    British7619430001
    HODGKINSON, David Percival, Dr
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish25256980001
    JACKMAN, Christopher Holgate
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British10419170001
    MARTIN, Rebecca Helen
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    Director
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    United KingdomNew Zealander134158470001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Director
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    EnglandBritish32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Director
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    SECRETI, Salvatore
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Director
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Canadian46635930001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    WOODWARD, Robert Stephen
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    Director
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    CanadaBritish30307660001

    ¿Tiene GEOQUEST HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 07 feb 1994
    Entregado el 21 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee under the terms of the facility documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 21 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 may 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 29 oct 1985
    Entregado el 31 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hongkong Bank Limited
    Transacciones
    • 31 oct 1985Registro de una carga
    Charge
    Creado el 02 may 1985
    Entregado el 22 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 30/11/84
    Breve descripción
    Assignment by way of charge of all right, title & interest of the company in all the inventions represented by letters patent of the united kingdom etc (for full details see doc M36).
    Personas con derecho
    • Wardley London Limited
    Transacciones
    • 22 may 1985Registro de una carga
    Letter of set-off
    Creado el 19 oct 1984
    Entregado el 02 nov 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descripción
    Any sums stading to the credit of any account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 02 nov 1984Registro de una carga
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 may 1983
    Entregado el 11 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, all buildings fixtures plant & machinery all stocks shares & securities.
    Personas con derecho
    • T R Trustees Corporation PLC
    • T R North America Investments Turst PLC
    • Wardley Limited
    Transacciones
    • 11 may 1983Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 09 may 1983
    Entregado el 11 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, all buildings fixtures. All plant & machinery all stocks shares & securities.
    Personas con derecho
    • Anthony Gibbs & Sons Limited
    Transacciones
    • 11 may 1983Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 16 ago 1982
    Entregado el 28 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery, all stocks, shares & other securities.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1982Registro de una carga
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GEOQUEST HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 dic 2009Inicio de la liquidación
    23 mar 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samuel Jonathan Talby
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath
    Profesional
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0