RENTMASTER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RENTMASTER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01492338 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RENTMASTER LIMITED?
- Alquiler y arrendamiento de automóviles y vehículos de motor ligeros (77110) / Actividades administrativas y de apoyo
- Alquiler y arrendamiento de camiones y otros vehículos pesados (77120) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra RENTMASTER LIMITED?
| Dirección de la sede social | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RENTMASTER LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FLEETLOGIC LIMITED | 10 mar 2010 | 10 mar 2010 |
| RENTMASTER LIMITED | 02 abr 2003 | 02 abr 2003 |
| SECURICOR RENTMASTER LIMITED | 24 jun 1996 | 24 jun 1996 |
| PCS RENTMASTER LIMITED | 01 sept 1995 | 01 sept 1995 |
| P.C.S. LIMITED | 15 abr 1985 | 15 abr 1985 |
| PORT CONTAINER SERVICES LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| FLOWFIRE LIMITED | 21 abr 1980 | 21 abr 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RENTMASTER LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RENTMASTER LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 abr 2025 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RENTMASTER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Registro de la carga 014923380082, creada el 19 may 2025 | 53 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Andrew Patrick Morley como director el 29 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Paul Dennis Hassall como director el 31 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 6 páginas | AA | ||
Registro de la carga 014923380081, creada el 18 dic 2019 | 54 páginas | MR01 | ||
Cese del nombramiento de David Bertram Barlow como director el 14 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Jarlath Partrick Skelly como director el 14 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jay Lee Edwards como director el 12 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Robert Jacques como director el 14 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David Barlow como director el 11 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de RENTMASTER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, Jay Lee | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | England | British | 235955560001 | |||||
| SKELLY, Jarlath Partrick | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | England | British | 263384680001 | |||||
| BARLOW, Charlotte Claire | Secretario | Butters Bank Croxton ST17 0XR Stafford Belle Cottage England | 196199650001 | |||||||
| BARLOW, David | Secretario | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | British | 89125150001 | ||||||
| MUNSON, Anne Patricia | Secretario | 21 Nymans Close RH12 5JR Horsham West Sussex | British | 64738610001 | ||||||
| NIXON, Diane | Secretario | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | 156677400001 | |||||||
| WEST, Philip Leslie | Secretario | Little Barn Pinners Lane Hasketon IP13 6HW Woodbridge Suffolk | British | 58602180001 | ||||||
| BARLOW, David Bertram | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | England | British | 172397880001 | |||||
| BARLOW, David | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 89125150002 | |||||
| BLOOM, Colin Preston Paul | Director | 27 Woodfields Stradbroke IP21 5JQ Eye Suffolk | England | British | 21182260001 | |||||
| CASLING, Richard Charles | Director | 25 Silverdale Avenue Oxshott KT22 0JX Leatherhead Surrey | England | British | 16966070002 | |||||
| DAVIES, Ronald | Director | Hill Farm Kettleburgh IP13 7LL Woodbridge Suffolk | England | British | 57426760001 | |||||
| DAVIES, Thomas Glyn | Director | The Old Rectory Church Lane Kirton IP10 0DX Ipswich Suffolk | British | 7457390001 | ||||||
| DIGHTON, Trevor Leslie | Director | The Black Barn Green Lane Marden TN12 9RA Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 148937480001 | |||||
| DOUGLAS, Lee | Director | 97 Bell Lane Kesgrave IP5 7LZ Ipswich Suffolk | British | 67806120001 | ||||||
| DUNNETT, Roy Victor | Director | Cherwell House Burstall Lane Sproughton IP8 3DJ Ipswich Suffolk | England | British | 7457410001 | |||||
| FINCH, Brian Clifford | Director | 30 Chelmerton Avenue Great Baddow CM2 9RF Chelmsford Essex | British | 45470380001 | ||||||
| FORMAN, Timothy | Director | 11 Ransome Close Sproughton IP8 3DG Ipswich Suffolk | British | 51752620001 | ||||||
| HASSALL, Paul Dennis | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 184294940001 | |||||
| HINES, Alan Ronald | Director | 7 Hawksview KT11 2PJ Cobham Surrey | British | 21071370001 | ||||||
| HOGAN, John Christopher James | Director | Touchwood Coolham Road, RH20 2LH West Chiltington West Sussex | United Kingdom | Irish | 84447970001 | |||||
| HOWES, Patrick David | Director | Tawny Lodge Beech Road NR12 8TP Wroxham Norfolk | British | 26934760003 | ||||||
| JACQUES, Paul Robert | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | England | British | 118835200001 | |||||
| MORLEY, Andrew Patrick | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | England | British | 184296160001 | |||||
| NEEDS, Colin David | Director | 191 Saunders Lane Mayford GU22 0NT Woking Surrey | British | 8171800001 | ||||||
| NIXON, Diane | Director | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | Great Britain | British | 92817950002 | |||||
| NORTON, Nicholas Charles | Director | 37 Rochester Avenue BR1 3DN Bromley Kent | British | 14467040002 | ||||||
| PECK, Ian Trevor | Director | 168 Chelsworth Road IP11 8UJ Felixstowe Suffolk | British | 41739980001 | ||||||
| RUSSELL, Nigel Peter | Director | The Wold Lynch Hill Park RG28 7NF Whitchurch Hampshire | United Kingdom | British | 20892640001 | |||||
| SCIORTINO, Roy Alfred | Director | 7 Freehold Road IP4 5HL Ipswich Suffolk | England | British | 30320140001 | |||||
| SHIRTCLIFFE, Christopher Charles | Director | Tankards Quarry Road RH8 9HE Oxted Surrey | British | 8503620001 | ||||||
| WALTON, Colin | Director | 6 Higginson Close CW12 3SU Congleton Cheshire | British | 89125550001 | ||||||
| WEST, Philip Leslie | Director | Little Barn Pinners Lane Hasketon IP13 6HW Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | 58602180001 | |||||
| WILKINSON, Michael Joseph | Director | Torrens Macdonald Road GU18 5YR Lightwater Surrey | British | 61587550002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RENTMASTER LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr David Barlow | 06 abr 2016 | React House Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke On Trent Staffordshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Prohire Group Limited | 06 abr 2016 | Spedding Road Fenton Industrial Estate ST4 2ST Stoke-On-Trent React House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0