JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.

JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01492610
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    • Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Dirección de la sede social
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    R I M LETTERBOX DIRECT LIMITED04 feb 199904 feb 1999
    D.D. DISTRIBUTION LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    FLAMENCO DEVELOPMENTS LIMITED22 abr 198022 abr 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    49 páginasAM23

    Domicilio social registrado cambiado de Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB el 17 mar 2020

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    55 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    5 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    57 páginasAM10

    Cese del nombramiento de Peter Mccall como secretario el 17 may 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David John King como director el 17 may 2019

    1 páginasTM01

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    5 páginasAM06

    Domicilio social registrado cambiado de Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG England a Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB el 10 dic 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de la propuesta del administrador

    123 páginasAM03

    Nombramiento de un administrador

    5 páginasAM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2017

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ashley Gilroy Mark Highfield como director el 05 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 ene 2016

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2016

    Estado de capital el 06 may 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Alan Stephen Plews como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alan Stephen Plews como director el 01 ago 2015

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 26 Whitehall Road Leeds LS12 1BE a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG el 04 ago 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 03 ene 2015

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 may 2015

    Estado de capital el 08 may 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2013

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    BritishCompany Director131295290001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary72684940002
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146964050001
    MILNES, Ann
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    Secretario
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary59652640002
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Secretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Secretario corporativo
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    Director
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    BritishCompany Director81185280001
    BARRETT, John Andrew
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    Director
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    BritishDirector9295350001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Director
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritishChief Operating Officer251394160001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Director
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishChief Executive136914890001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    LAVERICK, Susan Christine
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director99591930001
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Director
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    BritishDirector7475760001
    MILNER, Janet Mary
    Virginia Cottage
    Bishop Monkton
    HG3 3RQ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Virginia Cottage
    Bishop Monkton
    HG3 3RQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector9547100001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    OAKLEY, Christopher John
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector68410390001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    PLEWS, Alan Stephen
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritishManaging Director27819010002
    PLEWS, Alan Stephen
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Director
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director27819010002
    PLEWS, Alan Stephen
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Director
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Secretary27819010002
    RILEY, Mark Andrew
    3 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Director
    3 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director27806630002
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector9253330001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Johnston Publishing Limited
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    06 abr 2016
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroEngland
    Número de registro01919088
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 jun 2014
    Entregado el 01 jul 2014
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transacciones
    • 01 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    Deed of accession
    Creado el 25 sept 2009
    Entregado el 30 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Parties
    Transacciones
    • 30 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 17 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC Capital Markets(As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 17 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 feb 1998
    Entregado el 11 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs International (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 11 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 22 sept 1982
    Entregado el 06 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale there of fixed & floating charge undertaking and all propery and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 1982Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 22 sept 1982
    Entregado el 29 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Citicorp International Bank Limited
    Transacciones
    • 29 sept 1982Registro de una carga

    ¿Tiene JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 ago 2020Fin de la administración
    17 nov 2018Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Profesional
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0