APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01504036 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
- (3320) /
¿Dónde se encuentra APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 7 Kingsland Grange Woolston WA1 4SR Warrington Cheshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PERKIN-ELMER HOLDINGS LIMITED | 20 mar 1998 | 20 mar 1998 |
| PERKIN-ELMER (UK) LIMITED | 26 jun 1980 | 26 jun 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 sept 2012 | 7 páginas | 4.68 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Genoffir Maud Macleod como director el 26 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Martin como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 15 mar 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Dianne Marie Deuitch como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Souter como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 21 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2008 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lingley House 120 Birchwood Boulevard Warrington Cheshire WA3 7QH el 28 may 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2009 au 31 dic 2009 | 2 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Iain Martin el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACLEOD, Genoffir Maud | Secretario | 3 Fountain Driveoad PA4 9RF Paisley | British | 112690040002 | ||||||
| DEUITCH, Dianne Marie | Director | Kingsland Grange Woolston WA1 4SR Warrington 7 Cheshire England | Scotland | American | 156303760001 | |||||
| MACLEOD, Genoffir Maud | Director | Fountain Drive Inchinnan Business Park PA4 9RF Paisley 3 Scotland | Scotland | British | 186525060001 | |||||
| GOMEZ-PASCUAL, Jorge | Secretario | 16 Stothard Road Stretford M32 9HA Manchester Lancashire | Spanish | 125175730001 | ||||||
| HOLLAND, Andrew John | Secretario | 31 Weaverside Avenue WA7 3HE Runcorn Cheshire | British | 76047160001 | ||||||
| MARSHALL, Ian Frederick Charles | Secretario | 22 Meadowside Tilehurst RG31 5QE Reading | British | 55345380002 | ||||||
| SUTHERLAND, Janet | Secretario | The Old Parsonage Church Street North CW6 0QH Kelsall Tarporley Cheshire | Uk | 103230360001 | ||||||
| TAYLOR, Robert William Graham | Secretario | Firtree Cottage Puttenham Heath Road Compton GU3 1DY Guildford Surrey | British | 45980170001 | ||||||
| WILSON, Trevor Michael | Secretario | 26 Green Drive BB7 2BB Clitheroe Lancashire | British | 48896470001 | ||||||
| WREFORD, Simon George | Secretario | Twin Gables Vache Lane HP8 4SB Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 3370060001 | ||||||
| BARRETT, Peter | Director | 84 Lords Highway East Weston Fairfield Ct06883 Usa | American | 56621100001 | ||||||
| BERGERE, Clifford Wendell | Director | 45 Wilton Road East FOREIGN Ridgefield Ct Fairfield 06877 Usa | Us | 29980850001 | ||||||
| BEVENS, Barry Jameson | Director | 40 Rushmore Grove Paddington WA1 3EX Warrington | British | 62910060001 | ||||||
| BITTER, Frank Gordon | Director | 608 Cheese Spring Road New Canaan FOREIGN Connecticut 06840 Usa | Usa | 24893140001 | ||||||
| BROWN, Eric | Director | Knowle Rise Calvin Close GU15 1DN Camberley Surrey | British | 3670090001 | ||||||
| EMSWILER, William F | Director | 155 Cobblers Hill Road 06430 Fairfield Connecticut Usa | American | 36185570001 | ||||||
| FONGERN, Rainer Maria | Director | Parkweg 217 Voorburg 2271 Bb The Netherlands | German | 67364560001 | ||||||
| HADJADJEBA, Lionel Michel | Director | Fountain Drive Inchinnan Business Park PA4 9RF Paisley 3 Renfrewshire | French | 141087730001 | ||||||
| HOLMQVIST, Lars Erik | Director | Alpenstrasse 15 Ch 6300 Zug Switzerland | Swedish | 101694560001 | ||||||
| HOWE, Graham Peter, Dr | Director | Apartment G4 Sharon Green Apartments 35 Sharon Park Drive Menlo Park Ca94025 America | British | 92467500003 | ||||||
| JAEGER, Stephen Owen | Director | 11 Topstone Road Redding Connecticut 06896 FOREIGN Usa | American | 59629570001 | ||||||
| MARSHALL, Ian Frederick Charles | Director | 22 Meadowside Tilehurst RG31 5QE Reading | British | 55345380002 | ||||||
| MARTIN, Iain | Director | Kingsland Grange Woolston WA1 4SR Warrington 7 Cheshire England | England | British | 112188130001 | |||||
| MCQUILLIAN, John | Director | 11 Summerville Gardens Stockton Heath WA4 2EG Warrington | British | 54161920001 | ||||||
| MITCHELL, Paul Terence | Director | The Lindens School Lane Twyford MK18 4EY Buckingham Bucks | England | British | 54059390002 | |||||
| MORGAN, Walter Edward | Director | Winton Martinsend Lane HP16 9HS Great Missenden Buckinghamshire | British | 53377240001 | ||||||
| MURTON, Rodney | Director | Fawley Cottage 17 Dukes Wood Avenue SL9 7LA Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 3370080001 | ||||||
| PIGLIUCCI, Riccardo | Director | PO BOX 853 Rancho Santa Fe Ca 92067 Usa | United States | Italian | 117214400001 | |||||
| PIZZIE, Terence William | Director | Uplands 45 Park Road Golborne WA3 3PT Warrington | England | British | 88232970001 | |||||
| SOUTER, Thomas Ireland | Director | 3 Fountain Drive PA4 9RF Paisley | United Kingdom | British | 95848140002 | |||||
| TAYLOR, Robert William Graham | Director | Firtree Cottage Puttenham Heath Road Compton GU3 1DY Guildford Surrey | British | 45980170001 | ||||||
| WINGER, Dennis Lawrence | Director | 19 Prospect Ridge Quail Ridge Unit 56 Ridgefield Fairfield Ct06877 FOREIGN Usa | American | 56620020001 | ||||||
| WINHAM, Mark Anthony | Director | 6 Registry Close CW9 8UZ Northwich Cheshire | British | 87717540001 |
¿Tiene APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 19 may 2009 Entregado el 21 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The deposit account an interest bearing account in the name of the tenant and specifically designated at such bank or other institution as the landlord shall from time to time in its absolute discretion and notify the tenant see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit deed | Creado el 30 abr 2007 Entregado el 10 may 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £14,250 to be held in an interest earning account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture incorporating a fixed and floating charge | Creado el 23 feb 1998 Entregado el 27 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account or in respect of any transaction whatsoever | |
Breve descripción All of the property, assets and undertaking of the borrower, present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0