APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED

APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAPPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01504036
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    • (3320) /

    ¿Dónde se encuentra APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 Kingsland Grange
    Woolston
    WA1 4SR Warrington
    Cheshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PERKIN-ELMER HOLDINGS LIMITED20 mar 199820 mar 1998
    PERKIN-ELMER (UK) LIMITED26 jun 198026 jun 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 sept 2012

    7 páginas4.68

    Nombramiento de Mrs Genoffir Maud Macleod como director el 26 sept 2011

    2 páginasAP01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 sept 2011

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Iain Martin como director

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 15 mar 2011

    • Capital: GBP 1,800,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium reduced to nil 08/03/2011
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 17 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Miss Dianne Marie Deuitch como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas Souter como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    18 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    21 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2008

    23 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Lingley House 120 Birchwood Boulevard Warrington Cheshire WA3 7QH el 28 may 2010

    1 páginasAD01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2009 au 31 dic 2009

    2 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 17 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Iain Martin el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MACLEOD, Genoffir Maud
    3 Fountain Driveoad
    PA4 9RF Paisley
    Secretario
    3 Fountain Driveoad
    PA4 9RF Paisley
    British112690040002
    DEUITCH, Dianne Marie
    Kingsland Grange
    Woolston
    WA1 4SR Warrington
    7
    Cheshire
    England
    Director
    Kingsland Grange
    Woolston
    WA1 4SR Warrington
    7
    Cheshire
    England
    ScotlandAmerican156303760001
    MACLEOD, Genoffir Maud
    Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Paisley
    3
    Scotland
    Director
    Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Paisley
    3
    Scotland
    ScotlandBritish186525060001
    GOMEZ-PASCUAL, Jorge
    16 Stothard Road
    Stretford
    M32 9HA Manchester
    Lancashire
    Secretario
    16 Stothard Road
    Stretford
    M32 9HA Manchester
    Lancashire
    Spanish125175730001
    HOLLAND, Andrew John
    31 Weaverside Avenue
    WA7 3HE Runcorn
    Cheshire
    Secretario
    31 Weaverside Avenue
    WA7 3HE Runcorn
    Cheshire
    British76047160001
    MARSHALL, Ian Frederick Charles
    22 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Secretario
    22 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    British55345380002
    SUTHERLAND, Janet
    The Old Parsonage
    Church Street North
    CW6 0QH Kelsall Tarporley
    Cheshire
    Secretario
    The Old Parsonage
    Church Street North
    CW6 0QH Kelsall Tarporley
    Cheshire
    Uk103230360001
    TAYLOR, Robert William Graham
    Firtree Cottage Puttenham Heath Road
    Compton
    GU3 1DY Guildford
    Surrey
    Secretario
    Firtree Cottage Puttenham Heath Road
    Compton
    GU3 1DY Guildford
    Surrey
    British45980170001
    WILSON, Trevor Michael
    26 Green Drive
    BB7 2BB Clitheroe
    Lancashire
    Secretario
    26 Green Drive
    BB7 2BB Clitheroe
    Lancashire
    British48896470001
    WREFORD, Simon George
    Twin Gables
    Vache Lane
    HP8 4SB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secretario
    Twin Gables
    Vache Lane
    HP8 4SB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British3370060001
    BARRETT, Peter
    84 Lords Highway East
    Weston Fairfield Ct06883
    Usa
    Director
    84 Lords Highway East
    Weston Fairfield Ct06883
    Usa
    American56621100001
    BERGERE, Clifford Wendell
    45 Wilton Road East
    FOREIGN Ridgefield Ct
    Fairfield 06877
    Usa
    Director
    45 Wilton Road East
    FOREIGN Ridgefield Ct
    Fairfield 06877
    Usa
    Us29980850001
    BEVENS, Barry Jameson
    40 Rushmore Grove
    Paddington
    WA1 3EX Warrington
    Director
    40 Rushmore Grove
    Paddington
    WA1 3EX Warrington
    British62910060001
    BITTER, Frank Gordon
    608 Cheese Spring Road
    New Canaan
    FOREIGN Connecticut 06840
    Usa
    Director
    608 Cheese Spring Road
    New Canaan
    FOREIGN Connecticut 06840
    Usa
    Usa24893140001
    BROWN, Eric
    Knowle Rise
    Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    Director
    Knowle Rise
    Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    British3670090001
    EMSWILER, William F
    155 Cobblers Hill Road
    06430 Fairfield
    Connecticut
    Usa
    Director
    155 Cobblers Hill Road
    06430 Fairfield
    Connecticut
    Usa
    American36185570001
    FONGERN, Rainer Maria
    Parkweg 217
    Voorburg
    2271 Bb
    The Netherlands
    Director
    Parkweg 217
    Voorburg
    2271 Bb
    The Netherlands
    German67364560001
    HADJADJEBA, Lionel Michel
    Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Paisley
    3
    Renfrewshire
    Director
    Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Paisley
    3
    Renfrewshire
    French141087730001
    HOLMQVIST, Lars Erik
    Alpenstrasse 15
    Ch 6300 Zug
    Switzerland
    Director
    Alpenstrasse 15
    Ch 6300 Zug
    Switzerland
    Swedish101694560001
    HOWE, Graham Peter, Dr
    Apartment G4 Sharon Green
    Apartments 35 Sharon Park Drive
    Menlo Park
    Ca94025
    America
    Director
    Apartment G4 Sharon Green
    Apartments 35 Sharon Park Drive
    Menlo Park
    Ca94025
    America
    British92467500003
    JAEGER, Stephen Owen
    11 Topstone Road
    Redding Connecticut 06896
    FOREIGN Usa
    Director
    11 Topstone Road
    Redding Connecticut 06896
    FOREIGN Usa
    American59629570001
    MARSHALL, Ian Frederick Charles
    22 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Director
    22 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    British55345380002
    MARTIN, Iain
    Kingsland Grange
    Woolston
    WA1 4SR Warrington
    7
    Cheshire
    England
    Director
    Kingsland Grange
    Woolston
    WA1 4SR Warrington
    7
    Cheshire
    England
    EnglandBritish112188130001
    MCQUILLIAN, John
    11 Summerville Gardens
    Stockton Heath
    WA4 2EG Warrington
    Director
    11 Summerville Gardens
    Stockton Heath
    WA4 2EG Warrington
    British54161920001
    MITCHELL, Paul Terence
    The Lindens School Lane
    Twyford
    MK18 4EY Buckingham
    Bucks
    Director
    The Lindens School Lane
    Twyford
    MK18 4EY Buckingham
    Bucks
    EnglandBritish54059390002
    MORGAN, Walter Edward
    Winton Martinsend Lane
    HP16 9HS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Winton Martinsend Lane
    HP16 9HS Great Missenden
    Buckinghamshire
    British53377240001
    MURTON, Rodney
    Fawley Cottage 17 Dukes Wood Avenue
    SL9 7LA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Fawley Cottage 17 Dukes Wood Avenue
    SL9 7LA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British3370080001
    PIGLIUCCI, Riccardo
    PO BOX 853
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    Usa
    Director
    PO BOX 853
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    Usa
    United StatesItalian117214400001
    PIZZIE, Terence William
    Uplands
    45 Park Road Golborne
    WA3 3PT Warrington
    Director
    Uplands
    45 Park Road Golborne
    WA3 3PT Warrington
    EnglandBritish88232970001
    SOUTER, Thomas Ireland
    3 Fountain Drive
    PA4 9RF Paisley
    Director
    3 Fountain Drive
    PA4 9RF Paisley
    United KingdomBritish95848140002
    TAYLOR, Robert William Graham
    Firtree Cottage Puttenham Heath Road
    Compton
    GU3 1DY Guildford
    Surrey
    Director
    Firtree Cottage Puttenham Heath Road
    Compton
    GU3 1DY Guildford
    Surrey
    British45980170001
    WINGER, Dennis Lawrence
    19 Prospect Ridge Quail Ridge
    Unit 56 Ridgefield Fairfield Ct06877
    FOREIGN Usa
    Director
    19 Prospect Ridge Quail Ridge
    Unit 56 Ridgefield Fairfield Ct06877
    FOREIGN Usa
    American56620020001
    WINHAM, Mark Anthony
    6 Registry Close
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    Director
    6 Registry Close
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    British87717540001

    ¿Tiene APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 19 may 2009
    Entregado el 21 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit account an interest bearing account in the name of the tenant and specifically designated at such bank or other institution as the landlord shall from time to time in its absolute discretion and notify the tenant see image for full details.
    Personas con derecho
    • Industrial Property Investment Fund (Acting by Its General Partner Legal & General Property Partners (Industrial Fund) Limited
    Transacciones
    • 21 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deposit deed
    Creado el 30 abr 2007
    Entregado el 10 may 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £14,250 to be held in an interest earning account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Slough Industrial Estates Limited
    Transacciones
    • 10 may 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture incorporating a fixed and floating charge
    Creado el 23 feb 1998
    Entregado el 27 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account or in respect of any transaction whatsoever
    Breve descripción
    All of the property, assets and undertaking of the borrower, present and future.
    Personas con derecho
    • The Perkin-Elmer Corporation
    Transacciones
    • 27 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene APPLIED BIOSYSTEMS HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 abr 2013Fecha de disolución
    27 sept 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Bruce Cartwright
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Profesional
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Timothy Gerard Walsh
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Profesional
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0