ROCIALLE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROCIALLE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01510162
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROCIALLE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ROCIALLE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Intec 3 Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROCIALLE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROCIALLE INHEALTH LIMITED02 nov 200502 nov 2005
    ROCIALLE MEDICAL LIMITED31 jul 198031 jul 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROCIALLE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROCIALLE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    2 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Mark Leslie Franklin el 07 feb 2019

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Mark Franklin como director el 02 oct 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lesley Anne Batty como director el 13 sept 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Sunlight Clinical Solutions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 abr 2018

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Knightsbridge London SW1X 7LX England a Intec 3 Wade Road Basingstoke RG24 8NE el 03 abr 2018

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Lesley Anne Batty como director el 31 oct 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Quinn como director el 31 oct 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Andrew Lawler como secretario el 08 sept 2017

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Mr David Andrew Lawler el 26 abr 2017

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 4 Grosvenor Place London SW1X 7DL a 1 Knightsbridge London SW1X 7LX el 26 abr 2017

    1 páginasAD01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 1 Knightsbridge London SW1X 7LX

    1 páginasAD04

    Nombramiento de Mr Mark South como director el 23 dic 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Richard Finch como director el 22 dic 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Lawler como secretario el 22 dic 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Nigel James Hiorns como secretario el 22 dic 2016

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de ROCIALLE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FRANKLIN, Mark Leslie
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    Hampshire
    England
    Director
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    Hampshire
    England
    EnglandBritishWorkwear Rep251161800001
    SOUTH, Mark
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    Director
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    United KingdomBritishDirector221291190001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Secretario
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    FARBOUD, Azizeh
    The Masefield
    17 Wordsworth Grove Newnham
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretario
    The Masefield
    17 Wordsworth Grove Newnham
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    British21594110002
    HIORNS, Nigel James
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    Secretario
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    British11524610002
    LAWLER, David Andrew
    Knightsbridge
    SW1X 7LX London
    1
    England
    Secretario
    Knightsbridge
    SW1X 7LX London
    1
    England
    221202000001
    BALLINGER-FINCH, Louise Julia
    159 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    Director
    159 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishDirector124865840001
    BATTY, Lesley Anne
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    Director
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    EnglandBritishFinance Director196974110001
    EMBLETON, Denis Michael
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Director
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    EnglandBritishFinancial Director12722390003
    FARBOUD, Arash
    17 Wordsworth Grove
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    17 Wordsworth Grove
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishMarketing54062120001
    FARBOUD, Azizeh
    The Masefield
    17 Wordsworth Grove Newnham
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    The Masefield
    17 Wordsworth Grove Newnham
    CB3 9HH Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSecretary21594110002
    FARBOUD, Jahangir
    Lismore
    Whittlesford Road
    CB2 5EU Little Shelford
    Cambridgeshire
    Director
    Lismore
    Whittlesford Road
    CB2 5EU Little Shelford
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManaging Director97819900001
    FINCH, Steven Richard
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Director
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    United KingdomBritishDirector38003430003
    GIBSON, Alan James
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    Director
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector77962110001
    GIBSON, Alan James
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    Director
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director77962110001
    MOWER, Paul Fenton
    14 West Wratting Road
    Balsham
    CB1 6DX Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    14 West Wratting Road
    Balsham
    CB1 6DX Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishAccountant66241400001
    NEWTON, Ian Eric
    32 Kesteven Drive
    Market Deeping
    PE6 8DU Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    32 Kesteven Drive
    Market Deeping
    PE6 8DU Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant116404160001
    QUINN, Kevin
    Knightsbridge
    SW1X 7LX London
    1
    England
    Director
    Knightsbridge
    SW1X 7LX London
    1
    England
    EnglandBritishFinance Director89902020003
    RIPLEY, Alan Geoffrey
    Kedington House Mill Hill
    Kedington
    CB9 7NT Haverhill
    Suffolk
    Director
    Kedington House Mill Hill
    Kedington
    CB9 7NT Haverhill
    Suffolk
    BritishInternational Sales Director19588460002
    SOANES, David
    48 Hermitage Green
    RG18 9SL Hermitage
    Berkshire
    Director
    48 Hermitage Green
    RG18 9SL Hermitage
    Berkshire
    United KingdomEnglishCompany Director Ceo80021380004
    STURGESS, Stephen Mark
    22 Cambridge Street
    Wymington
    NN10 9LG Rushden
    Northamptonshire
    Director
    22 Cambridge Street
    Wymington
    NN10 9LG Rushden
    Northamptonshire
    EnglandBritishAccountant31871430001
    TURNER, Terence Frederick
    17 Fox Green
    Great Bradley
    CB8 9NR Newmarket
    Suffolk
    Director
    17 Fox Green
    Great Bradley
    CB8 9NR Newmarket
    Suffolk
    EnglandBritishPurchaser153968510001
    WHITECROSS, Philip James
    Lower Dean Farm
    Dean Road
    LU7 0EU Stewkley
    Bedfordshire
    Director
    Lower Dean Farm
    Dean Road
    LU7 0EU Stewkley
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector193730760001
    WHITECROSS, Philip James
    Lower Dean Farm
    Dean Road
    LU7 0EU Stewkley
    Bedfordshire
    Director
    Lower Dean Farm
    Dean Road
    LU7 0EU Stewkley
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director193730760001
    WILTON, Peter
    Fairoaks Wickham Road
    CB1 6QA Horseheath
    Cambridgeshire
    Director
    Fairoaks Wickham Road
    CB1 6QA Horseheath
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director44785330001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROCIALLE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sunlight Clinical Solutions Limited
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    06 abr 2016
    Wade Road
    RG24 8NE Basingstoke
    Intec 3
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Número de registro5233571
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ROCIALLE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 01 nov 2004
    Entregado el 12 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a cwmcynon business park northern plateau mountain ash rhondda t/no: WA832778. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 12 may 2003
    Entregado el 17 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 jul 2002
    Entregado el 14 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Equipment mortgage
    Creado el 17 feb 1999
    Entregado el 24 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Electron beam sterilisation system-serial no 145605-01.
    Personas con derecho
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transacciones
    • 24 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 30 dic 1998
    Entregado el 07 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Griffin Credit Services Limited
    Transacciones
    • 07 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 01 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 09 ene 1998
    Entregado el 14 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 nov 1997
    Entregado el 29 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The pirece of land situate at cwm cynon business park mountain ash as shown on the plan annexed to the form 395 and all buildings thereon. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 22 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 11 oct 1996
    Entregado el 18 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 18 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 01 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 06 mar 1992
    Entregado el 17 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £19025.60 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to all sums payable.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 17 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 09 ago 1988
    Entregado el 26 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1988Registro de una carga
    • 07 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 21 feb 1986
    Entregado el 27 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 1986Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0