BANDHART
Visión general
| Nombre de la empresa | BANDHART |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 01518375 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BANDHART?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BANDHART?
| Dirección de la sede social | C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham South Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BANDHART?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BLACK & DECKER PENSION TRUSTEE LIMITED | 23 sept 1980 | 23 sept 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BANDHART?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANDHART?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANDHART?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Mark Richard Smiley el 20 nov 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2025 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 17 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven John Costello el 17 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Stanley Black & Decker Uk Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mitre Secretaries Limited como secretario el 26 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Steven John Costello como secretario el 26 mar 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield S9 1XE a C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN el 31 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 22 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 22 jul 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Richard Smiley el 22 jul 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven John Costello el 22 jul 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 02 ago 2017 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BANDHART?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTELLO, Steven John | Secretario | Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane South Yorkshire United Kingdom | 321546360001 | |||||||||||
| COSTELLO, Steven John | Director | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | England | British | 217824350001 | |||||||||
| SMILEY, Mark Richard | Director | The Reach Bridge Avenue SL6 1QP Maidenhead C/O Stanley Black & Decker United Kingdom | England | British | 194271890001 | |||||||||
| SOOD, Amit Kumar | Director | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | England | British | 195541990002 | |||||||||
| COYNE, Julian | Secretario | 44 Thanstead Copse HP10 9YH Loudwater Buckinghamshire | British | 88220850001 | ||||||||||
| GREEN, Ronald David Pacey | Secretario | 9 Malting Way TW7 6SB Isleworth Middlesex | British | 2993400004 | ||||||||||
| HILL, Stephen Ronald | Secretario | 7 Cransbill Drive Bure Park OX26 3WG Bicester Oxfordshire | British | 78629670001 | ||||||||||
| JUDD, Norman Russell | Secretario | 3 Earleywood Pines Coronation Road SL5 9LH Ascot Berks | British | 47748190001 | ||||||||||
| STEVENS, Matthew | Secretario | 3 Honeysuckle Cottages Forest Road RG42 4HN Binfield Berkshire | British | 74257430001 | ||||||||||
| WATSON, Clive Graeme | Secretario | Woodlands 21 Stratton Road HP9 1HR Beaconsfield Buckinghamshire | British | 69872200005 | ||||||||||
| WHICHELOW, Roger Alfred | Secretario | 1 Rudd Hall Rise GU15 2JZ Camberley Surrey | British | 32240010001 | ||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England |
| 38565160001 | ||||||||||
| ALLAN, Michael J | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | United Kingdom | American | 102412950002 | |||||||||
| ALLAN, Michael J | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | United Kingdom | American | 102412950002 | |||||||||
| BOELEN, Sebastianus Antonius Theodorus | Director | 7 Highwaymans Ridge GU20 6JY Windlesham Surrey | United Kingdom | Dutch | 124455970001 | |||||||||
| CARR, Michael Edwin | Director | Church View Wapping HP18 9AL Long Crendon Bucks | British | 63429750001 | ||||||||||
| CHAKRAVARTHI, Giri Venkatesan | Director | 648 South Brooksvale Cheshire Connecticut 06418 U.S.A. | Usa | Us Citizen | 66249000001 | |||||||||
| COGZELL, Matthew James | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | England | British | 157755080001 | |||||||||
| COWLEY, John Mitchell | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | England | British | 153045530001 | |||||||||
| CRINCE, Marcelius | Director | St.Hubertusdreef 24 FOREIGN 3090 Overijse Belgium | Dutch | 75403540002 | ||||||||||
| DOUGLAS, Craig Argyle, Vice President And Treasurer | Director | Bath Road SL1 3YD Slough 210 Berkshire United Kingdom | United States | American | 95475550001 | |||||||||
| FENTON, Charles Eugene | Director | 215 Upnor Road IRISH Baltimore Md 21212 Usa | American | 39048810001 | ||||||||||
| FREEMAN, William Ian Bede | Director | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | 64442870001 | |||||||||
| GREEN, Ronald David Pacey | Director | 9 Malting Way TW7 6SB Isleworth Middlesex | British | 2993400004 | ||||||||||
| HILL, Stephen Ronald | Director | 7 Cransbill Drive Bure Park OX26 3WG Bicester Oxfordshire | British | 78629670001 | ||||||||||
| HOLMES, Jackie | Director | 5 Hurst Road SL1 6ND Slough Berkshire | British | 52921280001 | ||||||||||
| JOHNSTON, Gavin Henry Robert | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | England | British | 67359360002 | |||||||||
| JUDD, Norman Russell | Director | 3 Earleywood Pines Coronation Road SL5 9LH Ascot Berks | British | 47748190001 | ||||||||||
| KARSNER, Michael Stephen | Director | 17203 Wesley Chapel Road Monkton 21111 Maryland U.S.A. | American | 34666740001 | ||||||||||
| PAGE, Stephen Franklin | Director | 803 Katesford Road FOREIGN Hunt Valley Maryland 21030 Usa | Citizen Of The Usa | 5100840001 | ||||||||||
| POWELL-SMITH, Christopher Brian | Director | 210 Bath Road Slough SL1 3YD Berkshire | United Kingdom | British | 2430270002 | |||||||||
| RIVERS, Brian David | Director | 11 Hill Place SL2 3EW Farnham Common Buckinghamshire | British | 67651690002 | ||||||||||
| ROTHLEITNER, Mark Maxwell | Director | 10304 Princeton Circle Ellicott City Maryland 21042 Usa | Us Citizen | 59712370001 | ||||||||||
| SANDERSON, Antony Richard | Director | 3 Carlton Grange Gosforth, Newcastle Upon Tyne NE3 4QF Ne3 4qf | United Kingdom | British | 114998910001 | |||||||||
| SCHOEWE, Thomas Michael | Director | 14002 Fox Run Court Phoenix Maryland FOREIGN 21131 Usa | American | 38875530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BANDHART?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Uk Group Ltd | 21 dic 2018 | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Emhart International Limited | 06 abr 2016 | Europa Court Sheffield Airport Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0