ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01521000 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Dirección de la sede social | 20 Montford Place Kennington SE11 5DE London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HIRAM WALKER INTERNATIONAL LIMITED | 06 nov 1991 | 06 nov 1991 |
HIRAM WALKER-ALLIED VINTNERS INTERNATIONAL LIMITED | 08 mar 1988 | 08 mar 1988 |
HIRAM WALKER INTERNATIONAL LIMITED | 08 oct 1980 | 08 oct 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 sept 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 18 sept 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 sept 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mr Stuart Macnab el 01 jul 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Chivas House 72 Chancellors Road London W6 9RS a 20 Montford Place Kennington London SE11 5DE el 01 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 1 páginas | AA | ||
Nombramiento de Stuart Andrew Ferrie Mckechnie como director el 11 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELLS, Edward | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 274854930003 | ||||
MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | Scotland | British | Chartered Accountant | 264144930001 | ||||
EGAN, Jane | Secretario | 11 Mccrorie Place PA10 2BF Kilbarchan Renfrewshire | British | 112277750001 | ||||||
MACNAB, Stuart | Secretario | 6 Station Rise PA12 4NA Lochwinnoch Renfrewshire | British | 77024740001 | ||||||
MAINS, Thomas Gordon | Secretario | The Meadows Duck Lane BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip Somerset | British | Company Secretary | 46135720001 | |||||
TOMLINSON, John Michael | Secretario | 11 Selwood Crescent BA11 2HX Frome Somerset | British | 1356620001 | ||||||
WOOTERS, Joseph Michael | Secretario | Denny House Knowle Hill Farm Knowle Hill Chew Magna BS18 8TE Bristol Avon | American | 40378020001 | ||||||
AITKEN, Robert | Director | 21 Gloversfield Shipham BS25 1SU Winscombe Avon | British | Chartered Accountant | 16212230004 | |||||
BABEAU, Emmanuel Andre Marie | Director | 7 Rue Paul Chatrousse, 92200 Neuilly Sur Seine France | French | Company Director | 107414890001 | |||||
BROWN, Charles Bennett | Director | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | Chartered Secretary | 107840600001 | |||||
BURKE, Patrick Timothy | Director | The Chapel House Audley Lodge Audley Park Road BA1 2XL Bath | Irish | Director | 46429310002 | |||||
BURNETT, Kenneth Mackay, Dr | Director | 303 Tanglin Road FOREIGN Singapore | British | Director | 11348090003 | |||||
BURRELL, Peter Martin | Director | Orchard House 42 The Crescent Brinklow CV23 0LR Rugby Warwickshire | British | Chartered Accountant | 1970490001 | |||||
CAMPBELL, James David | Director | 24-25 Reybridge Lacock SN15 2PF Chippenham Wiltshire | British | Director | 29999050003 | |||||
CHALMERS, Martin Paul | Director | Dunnett Cottage Rackley Lane Compton Bishop BS26 2HJ Axbridge Somerset | United Kingdom | British | Finance Director Europe | 201126030001 | ||||
FETTER, Herve Denis Michel | Director | Spear Mews SW5 9NA London 6 | England | French | Finance Director | 133848930001 | ||||
FITZSIMONS, Ian Terence | Director | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | General Counsel | 116030190001 | |||||
GILLON, Patrick L'Estrange | Director | 9 Calonne Road SW19 5HH London | British | Director | 469830001 | |||||
HALES, Antony John | Director | Belvoir House Edstone Court Wootton Wawen B95 6DD Henley In Arden | United Kingdom | British | Director | 14399520001 | ||||
HILL, Richard Charles | Director | Oldeacre Northend Road BS49 4AT Yatton Somerset | England | British | European Finance Director | 78018370001 | ||||
HUYSSER, Edmond Peter Henri | Director | Loyolalaan 40 FOREIGN 5263 Av Vught Netherlands | Dutch | Director | 29999060001 | |||||
LYSTER, Peter John | Director | Arch Barn Quarry Springs Goathurst TA5 2DH Bridgwater Somerset | England | British | Director | 34011420003 | ||||
MACNAB, Stuart | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | Accountant | 77024740001 | ||||
MITCHELL, David Smith | Director | 16 Walpole Gardens TW2 5SJ Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Company Secretary | 1970560001 | ||||
QUARANTO, Leonard Anthony | Director | Glebe House Naunton GL54 3AT Cheltenham | American | General Counsel & Company Secr | 77989690001 | |||||
SCHOFIELD, Anthony | Director | Lomond House 9 Zetland Place EH5 3HU Edinburgh | United Kingdom | British | Finance Director | 53680030002 | ||||
SHEEN, Leonard William | Director | 4 The Eagles Yatton BS19 4QR Bristol | British | Director | 50164610002 | |||||
SMITH, Graham Hammond | Director | The Granary Station Road Wellow BA2 8QB Bath Avon | British | Director | 36016160001 | |||||
SMITH, Steven John | Director | The Laurels Old Coach Road BS26 2JB Lower Weare Somerset | British | British | Finance Director | 169265560001 | ||||
TURNER, Richard Graham | Director | Burnt House Farm West Stoughton BS28 4PW Wedmore Somerset | England | United Kingdom | Director | 9797070002 | ||||
TURPIN, Vincent | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | England | French | Chief Financial Officer | 237432170001 | ||||
WOOD, Peter Adrian Kinnear | Director | Aller House Chapel Allerton BS26 2AD Axbridge Somerset | British | Director | 43170740001 | |||||
WOOTERS, Joseph Michael | Director | Denny House Knowle Hill Farm Knowle Hill Chew Magna BS18 8TE Bristol Avon | American | Director | 40378020001 | |||||
ZANETTI, Christopher Frederick | Director | Jonathans Thatch Ramsdell Road Monk Sherborne RG26 5HS Tadley Hampshire | British | Director | 59648380002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (OVERSEAS) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allied Domecq Spirits & Wine Limited | 06 abr 2016 | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0