HARCOURT GROUP LIMITED

HARCOURT GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHARCOURT GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01524323
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HARCOURT GROUP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HARCOURT GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    20 Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARCOURT GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THORPAC GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY31 dic 198131 dic 1981
    BENSBECK LIMITED24 oct 198024 oct 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HARCOURT GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARCOURT GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Julia O'connor como secretario el 17 oct 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Marghub Ahmed Shaikh como secretario el 17 oct 2016

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 02 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Alexander Young como director el 18 ene 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Marghub Ahmed Shaikh como secretario el 23 sept 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Shokat Ali Akbar como secretario el 23 sept 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 02 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2015

    Estado de capital el 02 sept 2015

    • Capital: GBP 13,871,622
    SH01

    Cese del nombramiento de Khosrow Tahmasebi como director el 01 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Julia Helen O'connor como secretario el 18 mar 2015

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Isfryn Industrial Estate Blackmill Bridgend Mid Glamorgan CF35 6EQ a 20 Brickfield Road Birmingham B25 8HE el 20 mar 2015

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Shokat Ali Akbar como secretario el 18 mar 2015

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr John Alexander Young como director el 18 mar 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Leslie Smith como director el 18 mar 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ago 2014

    Estado de capital el 19 ago 2014

    • Capital: GBP 13,871,622
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Julia Helen O'connor como secretario

    1 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de HARCOURT GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    O'CONNOR, Julia
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    Secretario
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    216418430001
    SMITH, David Leslie
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Director
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    EnglandBritish189639980001
    AKBAR, Shokat Ali
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Secretario
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    196066620001
    BLAKEN, Stephen Graham
    Glyn Terrace
    Blaenclydach
    CF40 2EG Tonypandy
    4
    Mid Glamorgan
    Secretario
    Glyn Terrace
    Blaenclydach
    CF40 2EG Tonypandy
    4
    Mid Glamorgan
    British135666100001
    CANN, Andrew John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British10621040001
    GENTRY, Kenneth Victor
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Secretario
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British22290440001
    HARRIS, Michael James Robert
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    Secretario
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    British36974100002
    LOO, Helen Sork Ching
    4 Hollyhock Drive
    Brackla
    CF31 2NS Bridgend
    Mid Glamorgan
    Secretario
    4 Hollyhock Drive
    Brackla
    CF31 2NS Bridgend
    Mid Glamorgan
    British74360030001
    MALTHOUSE, James Leonard
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    Secretario
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    British37254960002
    MOSS, Nigel Adam
    29 Ossulton Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0DT London
    Secretario
    29 Ossulton Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0DT London
    British34044210003
    MURPHY, Michael Joseph
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    British31259900002
    O'CONNOR, Julia Helen
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Secretario
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    181014280001
    SHAIKH, Marghub Ahmed
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    Secretario
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    201219580001
    WILLIAMS, David Brian
    48 Victoria Road
    CF64 3HY Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Secretario
    48 Victoria Road
    CF64 3HY Penarth
    Vale Of Glamorgan
    British6237820001
    BOYD, Stephen David
    30 Dartmoor Drive
    PE18 8XT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    30 Dartmoor Drive
    PE18 8XT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish11136470002
    DOWLING, Christopher Bruce
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    Director
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    United KingdomAustralian28868820003
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Director
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    FRANKLIN, Grant Roger
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    Director
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    British4876290002
    FREEDMAN, Michael Anthony
    The Old Vicarage
    OX5 1AG Stanton Harcourt
    Oxfordshire
    Director
    The Old Vicarage
    OX5 1AG Stanton Harcourt
    Oxfordshire
    British53044160001
    GENTRY, Kenneth Victor
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Director
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British22290440001
    HARRIS, Michael James Robert
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    Director
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    United KingdomBritish36974100002
    HIND, John Douglas
    32 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    Director
    32 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish68009780002
    MALTHOUSE, James Leonard
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    Director
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    EnglandBritish37254960002
    MARTIN, John
    Bourne Park
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DG Andover
    Hampshire
    Director
    Bourne Park
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DG Andover
    Hampshire
    British22730300001
    MORGANS, Amanda Jane
    24 Riverside
    Winchcombe
    GL54 5JP Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    24 Riverside
    Winchcombe
    GL54 5JP Cheltenham
    Gloucestershire
    British42130090004
    MURPHY, Michael Joseph
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    British31259900002
    RHEAD, David Michael
    Cherry Trees 62 Little Sutton Lane
    Four Oaks
    B75 6PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Cherry Trees 62 Little Sutton Lane
    Four Oaks
    B75 6PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British29783670001
    TAHMASEBI, Khosrow
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    Director
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    United KingdomBritish38518070001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Director
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    British17203000001
    YOUNG, John Alexander
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Director
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    United KingdomBritish213099570001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HARCOURT GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Shabir Majid Alimahomed
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    06 abr 2016
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Arab Emirates
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene HARCOURT GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 mar 2002
    Entregado el 11 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited in Its Capacity as Security Trustee for the Loan Noteholders (The Trustee)
    Transacciones
    • 11 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 02 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture deed
    Creado el 08 mar 2002
    Entregado el 09 mar 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture deed
    Creado el 08 mar 2002
    Entregado el 09 mar 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 09 mar 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 28 abr 2000
    Entregado el 05 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company (formerly known as harcourt group PLC) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transacciones
    • 05 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 ene 2000
    Entregado el 02 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an offer letter dated 21ST september 1998
    Breve descripción
    Land and buildings on the south side of isfryn blackmill bridgend.
    Personas con derecho
    • The Welsh Development Agency
    Transacciones
    • 02 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 22 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 22 nov 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Legal mortgage
    Creado el 04 jul 1996
    Entregado el 09 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from C.I. converters limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/as siston centre kingswood bristol also k/as land on the north east side of station road kingswood bristol avon t/no av 86250 and av 215211 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 dic 1989
    Entregado el 02 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Sctoland PLC
    Transacciones
    • 02 ene 1990Registro de una carga
    • 12 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 oct 1984
    Entregado el 16 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 1 elliot road love lane industrial estate grencester gloucestershire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 1984Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 16 ago 1984
    Entregado el 21 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H. 12 wilkinson rd, cirencester gloucestershire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ago 1984Registro de una carga
    Chattels mortgage
    Creado el 17 feb 1984
    Entregado el 18 feb 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singuler the details plant machinery & items discribed in the schedule (for full details see doc M17).
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited.
    Transacciones
    • 18 feb 1984Registro de una carga
    Charge
    Creado el 25 jun 1981
    Entregado el 03 jul 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital,.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0