KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01529162
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MEDIPLAN ENGINEERING LIMITED19 nov 198019 nov 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 07 ene 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 18/12/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2017

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael James Flowers como director el 30 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2016

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Gregory Lewis como director el 19 ene 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 03 ene 2017

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Steven John Bowers como director el 30 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 ene 2016

    Estado de capital el 27 ene 2016

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2014

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Michael James Flowers el 13 mar 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 ene 2015

    Estado de capital el 02 ene 2015

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2013

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael James Flowers como director el 24 jul 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Director
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Director
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Director
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    HINCHCLIFFE, Alan
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    Director
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    EnglandBritish86931130002
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Director
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    United KingdomBritish42841660001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Director
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    POLASHEK, Robert Alister
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68036570001
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Director
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 jun 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2244623
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 mar 1993
    Entregado el 31 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 mar 1993
    Entregado el 31 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land k/a woodthorpe nhouse clapgate lane quinton birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 ene 1993
    Entregado el 29 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Factory premises at clapgate lane woodthorpe house woodgate valley birmingham together with all fixtures and fittings now or at any time herafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill of the business to the bank.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge,
    Creado el 10 sept 1992
    Entregado el 11 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC.
    Transacciones
    • 11 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1987
    Entregado el 24 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a woodthorpe house, clapgate lane, woodgate valley, birmingham, west midlands title no wm 247670.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1987Registro de una carga
    • 17 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 dic 1983
    Entregado el 10 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold woodthorpe house, clapgate lane halesowen west midlands title no wm 247670.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1983Registro de una carga
    Supplemental legal charge
    Creado el 16 nov 1982
    Entregado el 19 nov 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge on the book debts and other debts present and future.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 nov 1982Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 05 abr 1982
    Entregado el 08 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Freehold land floating to clapgate road, quinton, birmingham.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 08 abr 1982Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 17 feb 1982
    Entregado el 23 feb 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company & and/or sirebeck limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaing and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 feb 1982Registro de una carga
    • 17 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0