KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01529162 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MEDIPLAN ENGINEERING LIMITED | 19 nov 1980 | 19 nov 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 07 ene 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Flowers como director el 30 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Gregory Lewis como director el 19 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 03 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Bowers como director el 30 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael James Flowers el 13 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Flowers como director el 24 jul 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Secretario | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| EDGE, Geoffrey | Secretario | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
| VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Secretario | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
| BILLINGTON, Philip Gordon | Director | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | 18247670001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| CLEARY, Michael John | Director | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | 1525670001 | ||||||
| EDGE, Geoffrey | Director | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Director | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| GIBBS, Raymond John | Director | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | 85421380001 | ||||||
| HINCHCLIFFE, Alan | Director | Manor Cottage Tapton S43 1QQ Chesterfield | England | British | 86931130002 | |||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Director | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | 42841660001 | |||||
| MACDERMOTT, Philip | Director | 179 Sternhold Avenue SW2 4PF London | British | 25679470001 | ||||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| POLASHEK, Robert Alister | Director | 55 Park View Road B74 4PR Sutton Coldfield West Midlands | British | 68036570001 | ||||||
| PRICE, David John | Director | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Director | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Director | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
| WHITEHORN, Justin Michael | Director | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 42825970001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kembrey Electronics Limited | 30 jun 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 16 mar 1993 Entregado el 31 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 16 mar 1993 Entregado el 31 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land k/a woodthorpe nhouse clapgate lane quinton birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 ene 1993 Entregado el 29 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Factory premises at clapgate lane woodthorpe house woodgate valley birmingham together with all fixtures and fittings now or at any time herafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill of the business to the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge, | Creado el 10 sept 1992 Entregado el 11 sept 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 dic 1987 Entregado el 24 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a woodthorpe house, clapgate lane, woodgate valley, birmingham, west midlands title no wm 247670. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 20 dic 1983 Entregado el 10 ene 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold woodthorpe house, clapgate lane halesowen west midlands title no wm 247670. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental legal charge | Creado el 16 nov 1982 Entregado el 19 nov 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed charge on the book debts and other debts present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 abr 1982 Entregado el 08 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Freehold land floating to clapgate road, quinton, birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 17 feb 1982 Entregado el 23 feb 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company & and/or sirebeck limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed & floating charges undertaing and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0