TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED

TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01529353
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Auto Trader House Cutbushpark Industrial Estate Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ACORN COLOUR PRINT LIMITED19 may 198919 may 1989
    ABLEMARGIN LIMITED12 may 198812 may 1988
    ACORN WEB OFFSET LIMITED20 nov 198020 nov 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta03 abr 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 20 sept 2011

    • Capital: GBP 10
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 abr 2011

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stephen Lane como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Tara Collet como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Sean Glithero como secretario

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 mar 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Sean Glithero el 30 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Jenkin como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mrs Zillah Ellen Byng-Maddick como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Miller como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 6 Thatcham Business Village Colthrop Lane Thatcham Berkshire RG19 4LW el 15 oct 2009

    2 páginasAD01

    Cuentas preparadas hasta el 29 mar 2009

    5 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed acorn colour print LIMITED\certificate issued on 13/09/09
    3 páginasCERTNM

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GLITHERO, Sean
    Hyde End Road
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hyde End Road
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262
    Berkshire
    United Kingdom
    159905160001
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Finance Officer147214630001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Financial Controller160951420001
    GLITHERO, Sean Robert
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262 Hyde End Road
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262 Hyde End Road
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant129229070002
    ALLATT, Richard John
    3 Spencer Walk
    BD23 2TX Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    3 Spencer Walk
    BD23 2TX Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector34728560001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Secretario
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    BritishAccountant15959630001
    GRIFFITH, David Richard
    3 Foxcroft
    Church Crookham
    GU13 0JN Fleet
    Hampshire
    Secretario
    3 Foxcroft
    Church Crookham
    GU13 0JN Fleet
    Hampshire
    British42734490001
    HORNER, Angela Susan
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    British13754360001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Secretario
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    LACEY, Eugenia
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    Secretario
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    BritishTreasurer79114130001
    MAYCOCK, Terence
    10 Mentmore Gardens
    Appleton
    WA4 3HF Warrington
    Secretario
    10 Mentmore Gardens
    Appleton
    WA4 3HF Warrington
    BritishAccountant60515120001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    BritishDirector162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILNE, Warwick
    1 Whitland Avenue
    Heaton
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    Secretario
    1 Whitland Avenue
    Heaton
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    BritishDirector86677260001
    MORAN, Michael John
    97 Woodward Close
    Winnersh Farm
    RG11 5UU Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    97 Woodward Close
    Winnersh Farm
    RG11 5UU Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant49267860001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Secretario
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    FROGGETT, David
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director60401370001
    HARRIS, John Robert
    Court Haw
    Llanfair Talhairn
    LL22 8YP Abergele
    Conwy
    Director
    Court Haw
    Llanfair Talhairn
    LL22 8YP Abergele
    Conwy
    BritishNewspaper Executive33371970002
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Director
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    BritishAccountant6848030001
    HORNER, Angela Susan
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Birchview Birch Park
    Brockholes
    HD7 7BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director13754360001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Director
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    BritishAccountant86019470001
    HUNNINGS, Leonard William
    Melroy 26 Golf Links Road
    BH22 8BY Ferndown
    Dorset
    Director
    Melroy 26 Golf Links Road
    BH22 8BY Ferndown
    Dorset
    BritishPublisher6848040001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Director
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant123670600001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Director
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Director
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited KingdomCo Director155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Director
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    SCHOFIELD, Peter
    The Whitehouse
    Church Lane Nacton
    IP10 0ES Ipswich
    Suffolk
    Director
    The Whitehouse
    Church Lane Nacton
    IP10 0ES Ipswich
    Suffolk
    BritishManaging Director29860820002

    ¿Tiene TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Global accession deed
    Creado el 03 oct 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 nov 1989
    Entregado el 06 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings off pontefract road, normanton, wakefield west yorkshire t/nos wyk 449821 wyk 427708 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1989Registro de una carga
    • 14 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 18 mar 1988
    Entregado el 31 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefit of any licences legal mortgage over unit 3 carr lane industrial estate, lowmoor, bradford, west yorkshire. T.n wyk 391126 and/or proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1988Registro de una carga
    • 14 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 14 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 10 abr 1987
    Entregado el 18 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H unit b carr lane industrial estate law moor bradford county of west yorkshire.
    Personas con derecho
    • Whiteaway Laidlaw and Company Limited
    Transacciones
    • 18 abr 1987Registro de una carga
    • 19 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 ago 1986
    Entregado el 19 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery stocks shares other securities all intellectual property rights.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1986Registro de una carga
    • 14 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 22 mar 1984
    Entregado el 28 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 mar 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0