TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01529353 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Dirección de la sede social | Auto Trader House Cutbushpark Industrial Estate Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ACORN COLOUR PRINT LIMITED | 19 may 1989 | 19 may 1989 |
ABLEMARGIN LIMITED | 12 may 1988 | 12 may 1988 |
ACORN WEB OFFSET LIMITED | 20 nov 1980 | 20 nov 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 03 abr 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 20 sept 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 abr 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Lane como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Tara Collet como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sean Glithero como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 mar 2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sean Glithero el 30 sept 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jenkin como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Zillah Ellen Byng-Maddick como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Miller como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 6 Thatcham Business Village Colthrop Lane Thatcham Berkshire RG19 4LW el 15 oct 2009 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 29 mar 2009 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed acorn colour print LIMITED\certificate issued on 13/09/09 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLITHERO, Sean | Secretario | Hyde End Road Spencers Wood RG7 1DL Reading 262 Berkshire United Kingdom | 159905160001 | |||||||
BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Director | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 147214630001 | ||||
COLLET, Tara | Director | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | Group Financial Controller | 160951420001 | ||||
GLITHERO, Sean Robert | Director | Spencers Wood RG7 1DL Reading 262 Hyde End Road Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 129229070002 | ||||
ALLATT, Richard John | Secretario | 3 Spencer Walk BD23 2TX Skipton North Yorkshire | British | Director | 34728560001 | |||||
BESWITHERICK, David Peter | Secretario | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | Accountant | 15959630001 | |||||
GRIFFITH, David Richard | Secretario | 3 Foxcroft Church Crookham GU13 0JN Fleet Hampshire | British | 42734490001 | ||||||
HORNER, Angela Susan | Secretario | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | 13754360001 | ||||||
HOWARD, Katherine Frances | Secretario | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
JENKIN, Elizabeth | Secretario | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
LACEY, Eugenia | Secretario | 151 Ash Street GU12 6LJ Ash Surrey | British | Treasurer | 79114130001 | |||||
MAYCOCK, Terence | Secretario | 10 Mentmore Gardens Appleton WA4 3HF Warrington | British | Accountant | 60515120001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Secretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | Director | 162220750001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Secretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
MILNE, Warwick | Secretario | 1 Whitland Avenue Heaton BL1 5FB Bolton Lancashire | British | Director | 86677260001 | |||||
MORAN, Michael John | Secretario | 97 Woodward Close Winnersh Farm RG11 5UU Wokingham Berkshire | British | Accountant | 49267860001 | |||||
PERRISS, Robyn | Secretario | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | Accountant | 97879810002 | |||||
FROGGETT, David | Director | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 60401370001 | |||||
HARRIS, John Robert | Director | Court Haw Llanfair Talhairn LL22 8YP Abergele Conwy | British | Newspaper Executive | 33371970002 | |||||
HODGSON, Simon | Director | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | Accountant | 6848030001 | |||||
HORNER, Angela Susan | Director | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 13754360001 | |||||
HOWARD, Katherine Frances | Director | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | Accountant | 86019470001 | |||||
HUNNINGS, Leonard William | Director | Melroy 26 Golf Links Road BH22 8BY Ferndown Dorset | British | Publisher | 6848040001 | |||||
LANE, Stephen John Roger | Director | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | Accountant | 123670600001 | ||||
MILLER, Andrew Arthur | Director | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 162220750001 | ||||
MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Director | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | Co Director | 155633620001 | ||||
PERRISS, Robyn | Director | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | Accountant | 97879810002 | |||||
SCHOFIELD, Peter | Director | The Whitehouse Church Lane Nacton IP10 0ES Ipswich Suffolk | British | Managing Director | 29860820002 |
¿Tiene TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Global accession deed | Creado el 03 oct 2003 Entregado el 10 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 24 nov 1989 Entregado el 06 dic 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings off pontefract road, normanton, wakefield west yorkshire t/nos wyk 449821 wyk 427708 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 18 mar 1988 Entregado el 31 mar 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefit of any licences legal mortgage over unit 3 carr lane industrial estate, lowmoor, bradford, west yorkshire. T.n wyk 391126 and/or proceeds of sale thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 10 abr 1987 Entregado el 18 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H unit b carr lane industrial estate law moor bradford county of west yorkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 05 ago 1986 Entregado el 19 ago 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery stocks shares other securities all intellectual property rights. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 22 mar 1984 Entregado el 28 mar 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0