NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01530074
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED18 oct 199918 oct 1999
    STALWART RESIDENTIAL LIMITED22 nov 199422 nov 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 22 ago 2014

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 may 2014

    Estado de capital el 29 may 2014

    • Capital: GBP 721,874
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    13 páginasAA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    25 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Auth to allot shares & duty to avoid conflicts of interest 24/06/2013
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Minimum number of directors is one 24/06/2013
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 23 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cancelación total de la carga 2

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    5 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Roger Craine como director el 04 oct 2010

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Charles Woodcock como director el 04 oct 2012

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Roger Craine el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHAKESPEARE, Paul
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Secretario
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    British150997870001
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    Secretario
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    British69321020002
    DUGGAN, Helen
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    Secretario
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    British67744330001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Secretario
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    HARDING, Barrington Howard
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    Secretario
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    British11466730001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    PEARSON, Michael Adrian
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    Secretario
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    British59751140001
    TEMPLETON, William James, Dr
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Secretario
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    New Zealander27024160001
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Secretario
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    Secretario
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    British87931760001
    ARTHUR, Richard
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    Director
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    British71058650001
    BARRETT, Peter
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    Director
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    British75515090001
    BARTLETT, John Leonard
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    Director
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    British14120450001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Director
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish150997870001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Director
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritish106900580001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Director
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrish63716360005
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Director
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    British88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Director
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    Director
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    British21933520001
    DICKINSON, Stephen
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    British14120430001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Director
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    American78292660001
    DOWNEY, Paul Martin
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    British10360260002
    EVANS, David Thomas James
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    Director
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish62761080001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Director
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    GIRLING, Michael
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    Director
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    British63304110001
    HAMMOND, Anthony
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    British52752380001
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    Director
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish79961770002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Director
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritish13105310003
    HUGHFF, Victor William
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    Director
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    British6622110001
    MCLAY, William Morrison
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    Director
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    British54996780001
    MORGAN, Christopher
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    Director
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    United KingdomBritish33875890001
    NARRAWAY, Nicholas William
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    Director
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    British72113010001
    RAAB, Dennis Lynn
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    Director
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    American48186120003

    ¿Tiene NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 mar 1997
    Entregado el 09 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995
    Breve descripción
    L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transacciones
    • 09 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 may 1996
    Entregado el 30 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture)
    Breve descripción
    2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transacciones
    • 30 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 nov 1995
    Entregado el 30 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transacciones
    • 30 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 jun 1995
    Entregado el 05 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture)
    Breve descripción
    8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transacciones
    • 05 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1995
    Entregado el 06 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture
    Breve descripción
    The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 06 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security account agreement
    Creado el 24 mar 1995
    Entregado el 04 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Faciltiy Agreement))
    Transacciones
    • 04 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Collection account agreement
    Creado el 24 mar 1995
    Entregado el 04 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transacciones
    • 04 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 07 jul 1981
    Entregado el 13 jul 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1981Registro de una carga

    ¿Tiene NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 ago 2014Inicio de la liquidación
    26 dic 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0