DSG DIGITAL LONDON LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DSG DIGITAL LONDON LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01535111 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Dirección de la sede social | Deluxe House Unit 32, Segro Perivale Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DELUXE DIGITAL LONDON LIMITED | 07 ene 2008 | 07 ene 2008 |
| CAPITAL FX LIMITED | 17 oct 1990 | 17 oct 1990 |
| MIKE UDEN OPTICALS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| FICHETREE LIMITED | 16 dic 1980 | 16 dic 1980 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Deluxe House Deluxe House, Unit 32, Segro Perivale Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH England a Deluxe House Unit 32, Segro Perivale Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH el 30 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH England a Deluxe House Deluxe House, Unit 32, Segro Perivale Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH el 26 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Deluxe Limited Film House 142 Wardour Street London W1F 8DD England a Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH el 29 ene 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Grant Lyon como director el 02 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 11 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Eric Cummins como director el 06 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gary Grant Lyon como director el 06 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Ronald Perelman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 nov 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ralph Abraham Levy como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Michael Bell como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sirmad Balal Shafique como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Stefanie Liquori Digrigoli como director el 17 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUORI DIGRIGOLI, Stefanie | Director | Unit 32, Segro Perivale Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale Deluxe House England | United States | American | 262502870001 | |||||
| CATTERALL, Christopher Edward | Secretario | 20 Dukes Close SL9 7LH Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 115314860001 | ||||||
| CLEARY, David James | Secretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 217475920001 | |||||||
| CORNE, Richard | Secretario | Pickade House Risborough Road HP17 0XS Great Kimble Buckinghamshire | British | 141423560001 | ||||||
| DUFFILL, Clare Marianne | Secretario | 25 Landells Road SE22 9PG London | British | 71005690005 | ||||||
| LAWRENCE, Anne | Secretario | 15 Field Way HA4 7LY Ruislip Middlesex | British | 110992160001 | ||||||
| WATSON, James Neil | Secretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 194237530001 | |||||||
| ALLEN, Mark Anthony | Director | Garth Isaf Farmhouse CF72 9NH Llanharan | British | 107830700001 | ||||||
| BELL, Andrew Michael | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 117165060003 | |||||
| BIGGINS, Kenneth Walter | Director | 34 Richmond Hill Court TW10 6BD Richmond Surrey | England | British | 46166640002 | |||||
| BOULTON, Andrew William John | Director | Corner Cottage Fawley OX12 9NJ Wantage Oxfordshire | British | 12196060003 | ||||||
| BOULTON, Rosemary | Director | Corner Cottage Fawley OX12 9NJ Wantage Oxfordshire | British | 9152660003 | ||||||
| BUCKTON, Ian Andrew | Director | The Cottage Fancott Toddington LU5 6HT Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | 5107710002 | |||||
| CORNE, Richard | Director | Pickade House Risborough Road HP17 0XS Great Kimble Buckinghamshire | England | British | 141423560001 | |||||
| CUMMINS, John Eric | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 246542580001 | |||||
| DAVIDSON, Neil Patrick | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | Usa | American | 197003660001 | |||||
| DOUGHTY, Michael James | Director | 11 Merryfields UB8 2BT Uxbridge Middlesex | England | British | 46166570002 | |||||
| GURNEY, Patrick Philip | Director | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | British | 216332150001 | |||||
| HOWL, Roger Stuart | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 199288360001 | |||||
| JULIAN, Robert Keith | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 238211530001 | |||||
| LEVY, Ralph Abraham | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 253310550001 | |||||
| LYON, Gary Grant | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 275074850001 | |||||
| SHAFIQUE, Sirmad Balal | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United Kingdom | British | 157242840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Perelman | 06 abr 2016 | 35 East 62nd Street New York Macandrews & Forbs Building United States | Sí |
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para DSG DIGITAL LONDON LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 06 nov 2019 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene DSG DIGITAL LONDON LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 31 may 2013 Entregado el 04 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattel mortgage | Creado el 25 feb 2013 Entregado el 06 mar 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Protape datastores - 10 x dx 115 & simtronics 500GB, protape datastores - 149 cru caddy 6601-7100-0500 seagate 500GB internal 7.2 rpm ST500DM002,hammer PLC - V2R-cru-movedock hdd in move dock for details of further chattels charged please refer to form MG01 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattels mortgage | Creado el 15 dic 2011 Entregado el 17 dic 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Hdd in move dock 191952/(1-200)-910-A. DX115 dc carrier cru-6601-7103-0500, hdd in move dock 217756/(1-658)-0411-a, 217761/(1-455)-0411-a, 217761/(1-4)-0411-a, for further details of chattels charged please refer to form MG01. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattels mortgage | Creado el 30 jun 2011 Entregado el 01 jul 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The equipment being: V2 disk subsystem digital recording equipment, V2 disk subsystem serial no 192564, V2 disk subsystem serial no 193533, for details of further equipment charged, please refer to form MG01, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 06 ago 2008 Entregado el 12 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción A deposit of £1,269,000. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 14 dic 1995 Entregado el 23 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of rent deposit | Creado el 06 oct 1993 Entregado el 08 oct 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Breve descripción A rent deposit in the sum of £11,658.38 or any increased sum payable under the provisions of the deed of rent deposit. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of rent deposit | Creado el 06 oct 1993 Entregado el 08 oct 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rent deposit deed of even date | |
Breve descripción A rent deposit in the sum of £4,484.99 or any increased sum payable underthe provisions of the deed of rent deposit. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 ene 1983 Entregado el 08 feb 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Leasehold. 21A kingly court, kingly street, westminster, london W1R 5LE. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 ene 1982 Entregado el 03 feb 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0