MORGAM HOLDINGS LIMITED

MORGAM HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMORGAM HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01536782
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MORGAM NEWS HOLDINGS LIMITED31 dic 198031 dic 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 feb 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 páginasAD03

    Domicilio social registrado cambiado de Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF el 24 ene 2018

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 páginasAD02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 05 ene 2018

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 dic 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 11/12/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Steven Blair como director el 08 dic 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert John Welch como director el 08 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tesco Services Limited como director el 08 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Tracey Clements como director el 08 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonny Mcquarrie como director el 08 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2017

    4 páginasAA

    Nombramiento de Jonny Mcquarrie como director el 17 oct 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Steven Blair como director el 17 oct 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Tesco Services Limited como director el 31 ago 2017

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mrs Tracey Clements como director el 31 ago 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Benjamin Williams como director el 22 feb 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Paul King como director el 22 feb 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    160914200001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    MCAULEY, Ann
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    Secretario
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    British3954600002
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British1537420008
    BARTON, Tracy Jayne
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160642760001
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    BRADBEER, Jeremy
    The Croft Hillcrest Cottage
    Preston Bagot Henley In Arden
    B95 5DR Solihull
    West Midlands
    Director
    The Croft Hillcrest Cottage
    Preston Bagot Henley In Arden
    B95 5DR Solihull
    West Midlands
    British60121580001
    BYTHEWAY, Neil Trevor
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160637140001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    GILES, Anthony Edward
    Home Farm Cottage
    Pepper Street Inkberrow
    WR7 4EJ Worcester
    Director
    Home Farm Cottage
    Pepper Street Inkberrow
    WR7 4EJ Worcester
    British3555100002
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LINSELL, Richard Charles
    6 Aubrey Close
    West Town
    PO11 0SU Hayling Island
    Hampshire
    Director
    6 Aubrey Close
    West Town
    PO11 0SU Hayling Island
    Hampshire
    EnglandBritish1595570002
    LLOYD, Jonathan Mark
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160028560001
    MCAULEY, Ann
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    Director
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    British3954600002
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish1537420008
    MOORE, Andrew William
    24 Ashwell Drive
    Shirley
    B90 3LR Solihull
    West Midlands
    Director
    24 Ashwell Drive
    Shirley
    B90 3LR Solihull
    West Midlands
    British78389210001
    MOORE, Martin Stephen
    Hollington Lodge
    Whitley Hill
    B95 5DL Henley In Arden
    West Midlands
    Director
    Hollington Lodge
    Whitley Hill
    B95 5DL Henley In Arden
    West Midlands
    British3238160002
    MOORE, Robert Philip
    The Old Vicarage
    Lower Quinton
    CV37 8SH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    The Old Vicarage
    Lower Quinton
    CV37 8SH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish3238150001
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish148079740001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    SAFFERY, John Robert
    46 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    Director
    46 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    British2013700001
    STOKOE, Martin Geoffrey
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    Director
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish49671990001
    WILLIAMS, Mark Benjamin
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish208244710001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7600956
    175259630001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7600956
    175259630001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MORGAM HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3381179
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MORGAM HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 24 may 2004
    Entregado el 05 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a 52 ledwell, dickens heath, west midlands. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 sept 2003
    Entregado el 19 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 sept 2003
    Entregado el 19 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    276 vicarage road kings heath birmingham B14 7NH title absolute t/n WM24877 (for details of further properties charged please refer to form 395). with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 07 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 ene 2001
    Entregado el 13 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Girobank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 07 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 sept 1995
    Entregado el 22 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unis 20-24, 31 & 32 bidavon industrial estate waterloo road bidford on avon warwickshire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 ago 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 may 1991
    Entregado el 15 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on the north west side of stanhope street highgate 55 stanhope street birmingham W. mids t/no wk 72766 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 1991Registro de una carga
    • 09 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 may 1991
    Entregado el 15 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on north east side of emily street 8/10 emily street birmingham west mids t/no. Wk 216186 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 1991Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 dic 1990
    Entregado el 06 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a 128 lea village yardley, birmingham t/no wk 93736. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 sept 1990
    Entregado el 26 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H old property k/as land to the east of percy road birmingham west midlands title no. Wm 147167. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 sept 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 sept 1990
    Entregado el 24 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/as 46 queen street cubbington leamington spa title no. Wk 270684. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 sept 1990
    Entregado el 24 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/as 5 hockley birmingham title no. Wk 64287. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 sept 1990
    Entregado el 24 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/as 38 kenpas highway coventry title no. Wk 98544. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 sept 1990
    Entregado el 24 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/as 276 vicarage road kings heath birmingham title no wm 24877. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 feb 1990
    Entregado el 01 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/as 349 warwick road, solihull, west midlands. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 feb 1990
    Entregado el 01 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/as 355 haslucks green road birmingham title number wk 228927. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 feb 1990
    Entregado el 01 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/as 114 blenehim road, birmingham title number wm 30554. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 31 ene 1990
    Entregado el 08 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    272/274 cranmore boulevard, shirley, solihull west midlands or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 1990Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 jul 1982
    Entregado el 05 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h properties fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1982Registro de una carga
    • 13 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 abr 1982
    Entregado el 22 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • County Bank Limited
    Transacciones
    • 22 abr 1982Registro de una carga

    ¿Tiene MORGAM HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 ene 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0