ACT OVERSEAS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACT OVERSEAS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01543895
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACT OVERSEAS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ACT OVERSEAS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACT OVERSEAS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BIS INTERNATIONAL LIMITED09 feb 198109 feb 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACT OVERSEAS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACT OVERSEAS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    15 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 feb 2017

    8 páginas4.68

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 25 feb 2016

    LRESSP

    legacy

    60 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 jul 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 29/07/2015
    RES13

    Nombramiento de Mr Johannes Jacobus Olivier como director el 20 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Paul Woodward como director el 20 jul 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 jun 2015

    Estado de capital el 01 jun 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2014

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Paul Woodward como director el 05 sept 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sanjay Patel como director el 28 ago 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Van Harken como director el 31 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Mary Collins como director el 31 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jun 2014

    Estado de capital el 04 jun 2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2013

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Elizabeth Mary Collins como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Misys Corporate Director Limited como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ACT OVERSEAS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth African199516920001
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    Secretario
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Secretario corporativo
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07036299
    149977350001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Director
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLANAGAN, Andrew Henry
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    Director
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    British42787120001
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GRAHAM, George Malcolm Roger
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish36314420001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Director
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Director
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Director
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Director corporativo
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    ¿Tiene ACT OVERSEAS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 01 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 24 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creado el 29 jul 2003
    Entregado el 12 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creado el 23 oct 2002
    Entregado el 13 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene ACT OVERSEAS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 dic 2017Fecha de disolución
    25 feb 2016Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profesional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0