MISYS KBS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMISYS KBS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01545543
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MISYS KBS LIMITED?

    • Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra MISYS KBS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MISYS KBS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KINDLE BANKING SYSTEMS LIMITED17 oct 199517 oct 1995
    ACT BANKING SYSTEMS (U.K.) LIMITED14 abr 199414 abr 1994
    ACT KINDLE (U.K.) LIMITED04 jun 199204 jun 1992
    KINDLE LIMITED29 nov 198529 nov 1985
    TRIPLE A SYSTEMS LIMITED25 abr 198325 abr 1983
    M.A. SOFTWARE LIMITED17 mar 198217 mar 1982
    M.A. SYSTEMS (LONDON) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    PEACEPAR LIMITED13 feb 198113 feb 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MISYS KBS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MISYS KBS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 may 2016

    28 páginas4.68

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 may 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 23 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 ene 2015

    Estado de capital el 23 ene 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2014

    12 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Paul Woodward como director el 05 sept 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sanjay Patel como director el 28 ago 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Van Harken como director el 31 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Mary Collins como director el 31 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2014

    Estado de capital el 06 feb 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 may 2013

    12 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Elizabeth Mary Collins como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Misys Corporate Director Limited como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Joanna Hawkes como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Misys Corporate Secretary Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Sanjay Patel como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Joanna Marageret Hawkes como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Bijal Patel como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Edward Timothy Homer el 20 may 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 23 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 may 2012

    12 páginasAA

    Nombramiento de Mr Bijal Mahendra Patel como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de MISYS KBS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    Secretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    146638700001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07036299
    170449080001
    CLANCY, Conall Patrick
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Director
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish37703500001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COLWELL, John
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    Director
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    British98195430003
    DERRER, Andrew Jan
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    Director
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    EnglandBritish121601200001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Director
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Director
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    KILDUFF, Martin Anthony
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Director
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish32778090001
    MEANY, Patrick Declan
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Director
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Irish82121570001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NOCTOR, Desmond James
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Director
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Irish32778100001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    STOKES, Mark
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Director
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Irish82121580001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Director
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    SUSSENS, John Gilbert
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1442450001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director corporativo
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro04217573
    158141250001

    ¿Tiene MISYS KBS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 01 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 24 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creado el 29 jul 2003
    Entregado el 12 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creado el 23 oct 2002
    Entregado el 13 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creado el 09 may 2002
    Entregado el 25 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 23 ene 1987
    Entregado el 28 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's book debts and other receivables present and future.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 28 ene 1987Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 nov 1986
    Entregado el 18 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 18 nov 1986Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of collateral debenture
    Creado el 26 may 1986
    Entregado el 16 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from kindle group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    By way of floating security all the company's undertaking and assets present and future including uncalled capital for the time being & goodwill.
    Personas con derecho
    • Industrial Credit Corporation PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1986Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of chattel mortgage
    Creado el 26 may 1986
    Entregado el 16 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge on all the property & assets listed in doc M29. (See doc M29 for details).
    Personas con derecho
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1986Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 19 jun 1985
    Entregado el 03 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the M. A. bereau services LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoerver both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill.
    Personas con derecho
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1985Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 19 jun 1985
    Entregado el 03 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the M. A. systems LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital fot the time being and goodwill.
    Personas con derecho
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1985Registro de una carga
    • 05 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene MISYS KBS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 oct 2017Fecha de disolución
    27 may 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profesional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0