HDL (CATERING) LIMITED

HDL (CATERING) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHDL (CATERING) LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 01561361
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HDL (CATERING) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra HDL (CATERING) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HDL (CATERING) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SEDDONS FOODS LIMITED26 feb 198826 feb 1988
    SEDDONS-PALATINE LIMITED14 may 198114 may 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HDL (CATERING) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 ene 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HDL (CATERING) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HDL (CATERING) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    CERTIPS

    Misceláneos

    Forms b & z to convert to i&ps
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to i&ps 17/06/2011
    RES13

    Nombramiento de Mr Steven Clive Bailey como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Humes como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jul 2011

    Estado de capital el 21 jul 2011

    • Capital: GBP 1,416
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2011

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stephen Humes el 01 ago 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hurrell el 01 ago 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 17 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2010

    4 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 11 ene 2010 au 02 ene 2010

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mrs Caroline Jane Sellers como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Katherine Eldridge como secretario

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 10 ene 2009

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 12 ene 2008

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de HDL (CATERING) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secretario
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150084390001
    BAILEY, Steven Clive
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish99724260001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Secretario
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    British10084840001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Secretario
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Secretario
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UNITED CO OPERATIVES SECRETARY LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secretario corporativo
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110061750001
    ASPRAY, Rodney George
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    Director
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    British2637360001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Director
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    FLITCROFT, Kevin
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    Director
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    British13792010001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HUNT, Walter Kenneth
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    Director
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    British9318100001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Director
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KNOWLES, John Keith
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    Director
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    British13791990001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Director
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    MCGOERN, Alan
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    Director
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    British28940610001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Director
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Director
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Director
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    STEVENSON, Brian
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    Director
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    British13792000001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Director
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UNITED CO OPERATIVES DIRECTOR 1 LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Director corporativo
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110062190001

    ¿Tiene HDL (CATERING) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 13 abr 1989
    Entregado el 21 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a wesley mill, bamber bridge, preston, lancs.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1989Registro de una carga
    • 02 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 abr 1989
    Entregado el 21 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1989Registro de una carga
    • 02 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 31 ago 1988
    Entregado el 12 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1988Registro de una carga
    • 02 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ago 1988
    Entregado el 12 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being wesley mill off club street bamber bridge preston.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1988Registro de una carga
    • 02 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 22 ago 1988
    Entregado el 23 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All & singular the chattels, plant, machinery & terms described on form 395 (for full details see form 395).
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 23 ago 1988Registro de una carga
    • 04 jun 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 1988
    Entregado el 11 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way fo legal mortgage:- f/hold land together with the buildings erected thereon situate off club street, bamber bridge south ribble lancs. Together with a right of way over and along the adjoining roadway leading to club st aforesaid fixed charge over plant, machienry implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 abr 1988Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 26 feb 1988
    Entregado el 18 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Upk 55,000 one pound 5% second debenture loan stock and all monies due supplemental to a loan stock agreement of even date.
    Breve descripción
    All freehold & leasehold property, goodwill, book debts, undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • John Keith Knowles
    Transacciones
    • 18 mar 1988Registro de una carga
    • 02 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 abr 1984
    Entregado el 09 abr 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge and undertaking and all property and assets present and future including godwill book & other debts uncalled capital. Together with all fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1984Registro de una carga
    Charge
    Creado el 27 may 1981
    Entregado el 02 jun 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jun 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0