INTERCITY CONSULTANTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTERCITY CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01563022 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Dawson House 5 Jewry Street EC3N 2EX London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RINGPLACE LIMITED | 20 may 1981 | 20 may 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR a Dawson House 5 Jewry Street London EC3N 2EX el 15 abr 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Roger Harold Antony como secretario el 30 jun 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair John Lomond Woolley como secretario el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Roger Harold Antony como director el 30 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair John Lomond Woolley como director el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 11 Golden Square London W1F 9JB England a 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR el 09 dic 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Wimbeldon Bridge House C/O Parity Group Plc 1St Floor 1 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3RU a 11 Golden Square London W1F 9JB el 25 sept 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alastair John Lomond Woolley como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Ketchin como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Ketchin como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY, Roger Harold | Secretario | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | 199307430001 | |||||||
| ANTONY, Roger Harold | Director | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | England | British | 199013040001 | |||||
| FIRTH, David Samuel Peter | Secretario | Wood Mill House Shoreham Road BN5 9SD Henfield West Sussex | British | 77398810001 | ||||||
| HARRIS, Christopher John | Secretario | 73 Chart Lane RH2 7EA Reigate Surrey | British | 37108360001 | ||||||
| KELLY, Joseph Patrick | Secretario | 39 Manor Road AL4 8JG Wheathamsread Herts | British | 61057590001 | ||||||
| KETCHIN, Ian Malcolm | Secretario | 118 Goddington Lane BR6 9DZ Orpington Kent | British | 93777900002 | ||||||
| LEYSHON, Alison Jane | Secretario | 30 Foster Road Chiswick W4 4NY London | British | 65584930003 | ||||||
| MOSS, Ronald Allen | Secretario | Stonechat Frithsden Copse HP4 1NN Berkhamsted Hertfordshire | British | 6787850003 | ||||||
| SIMMONDS, Stephen William | Secretario | 15 Hyde Lane Nash Mills HP3 8RY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 28604570001 | ||||||
| WATKINSON, Ed | Secretario | Aberue Bridge Street YO51 9LA Boroughbridge North Yorkshire | British | 106937690001 | ||||||
| WOOLLEY, Alastair John Lomond | Secretario | Bath Place Rivington Street EC2A 3DR London 2 England | 159204550001 | |||||||
| HUGHES, John Llewellyn Mostyn | Director | Albion Riverside 8 Hester Road SW11 4AR London C77 | Uk | British | 104248860001 | |||||
| KELLY, Joseph Patrick | Director | 39 Manor Road AL4 8JG Wheathamsread Herts | British | 61057590001 | ||||||
| KETCHIN, Ian Malcolm | Director | 118 Goddington Lane BR6 9DZ Orpington Kent | England | British | 93777900002 | |||||
| LEYSHON, Alison Jane | Director | 30 Foster Road Chiswick W4 4NY London | British | 65584930003 | ||||||
| MILLER, Ian Kenneth | Director | 4234 Lomo Alto Court Dallas Tx75219 Usa | United Kingdom | Scottish | 89546660001 | |||||
| MOSS, Ronald Allen | Director | Stonechat Frithsden Copse HP4 1NN Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 6787850003 | |||||
| O'DRISCOLL, Ian | Director | Two Goods Farm Moorside DT10 1HQ Marnhull Dorset | British | 68202110001 | ||||||
| SHARPE, William John Ashdown | Director | Leawood Cottage Northchurch Common HP4 1LR Berkhamstead Hertfordshire | British | 10140350001 | ||||||
| SIMMONDS, Stephen William | Director | 15 Hyde Lane Nash Mills HP3 8RY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 28604570001 | ||||||
| TRIGG, Stephen John | Director | 3 The Orchards 72 Oxford Road Stone HP17 8PL Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | 31432190006 | |||||
| WELCH, Alwyn Frank | Director | Coniston Farnham Lane GU27 1EZ Haslemere Surrey | England | British | 56811010001 | |||||
| WOOLLEY, Alastair John Lomond | Director | Bath Place Rivington Street EC2A 3DR London 2 England | United Kingdom | British | 89506550002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Css Software Solutions Ltd | 06 abr 2016 | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene INTERCITY CONSULTANTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 19 jun 1990 Entregado el 21 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage the l/h property known as on being suite 6, scott house admirals way london E14 9UG including the entites of the property comprisal in land colificate title no egl 178517 together with all buildings and fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 dic 1988 Entregado el 23 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 18 sept 1987 Entregado el 23 sept 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 80 wapping high street london E1 title no ngl 180934. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 18 sept 1987 Entregado el 23 sept 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 6 scott house waterside marsh wall isle of dogs london title no - egl 178517. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 31 jul 1987 Entregado el 07 ago 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold 80 wapping high street london E7 assignment of the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 03 abr 1987 Entregado el 22 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 80 wapping high street london E7. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 09 mar 1987 Entregado el 18 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Empire site 6 scott howe, isle of dogs london EC4. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 dic 1983 Entregado el 06 ene 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0