SAWP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSAWP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01565544
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SAWP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SAWP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Loudwater Mill
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SAWP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTHERN AND WESTERN PRESS LIMITED15 nov 198415 nov 1984
    SURREY PROPERTY MAIL LIMITED02 jun 198102 jun 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SAWP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SAWP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Estado de capital el 28 mar 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c and capital reserve 09/03/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2016

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 may 2016

    Estado de capital el 19 may 2016

    • Capital: GBP 13,557.05
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 26 nov 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2015

    Estado de capital el 18 may 2015

    • Capital: GBP 13,557.05
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 13 ene 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 13 ene 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del secretario Simon Alton Westrop el 13 ene 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Henry Kennedy Faure Walker el 13 ene 2015

    2 páginasCH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY el 11 dic 2014

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Paul Davidson como director el 11 nov 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 may 2014

    Estado de capital el 07 may 2014

    • Capital: GBP 13,557.05
    SH01

    Nombramiento de Henry Kennedy Faure Walker como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SAWP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishFinance Director69320190004
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Secretario
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    British7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Secretario
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    GLASS, Josephine Mary
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    Secretario
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    British44504060001
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Secretario
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    TOWNSEND, John Arthur
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    Secretario
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    British7332310001
    AIKEN, Iain William
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    Director
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    BritishNewspaper Publisher83849650001
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Director
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    BritishCompany Secretary7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Director
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Director
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    BritishNewspaper Chief Exec4154210013
    CHRISTIE, David Gordon
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    Director
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    BritishNewspaper Publisher75461250001
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46356560004
    GRAHAM, John Stuart
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    Director
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    BritishChartered Accountant72224100001
    HARRIS, Philip James
    18 Palairet Close
    BA15 1US Bradford On Avon
    Wiltshire
    Director
    18 Palairet Close
    BA15 1US Bradford On Avon
    Wiltshire
    BritishNewspaper Director26617980001
    MATTHEWS, David John
    17 Orwell Drive
    Keynsham
    BS18 1QB Bristol
    Avon
    Director
    17 Orwell Drive
    Keynsham
    BS18 1QB Bristol
    Avon
    BritishAccountant26617990001
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Director
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritishFinance Director93412530001
    RADBURN, Philip Arthur
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    Director
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46357310001
    SKINNER, Peter John
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    Director
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    BritishChartered Accountant7332340001
    STEVENSON, Hew Shannan
    42 Canonbury Square
    N1 2AW London
    Director
    42 Canonbury Square
    N1 2AW London
    BritishNewspaper Director8030630001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SAWP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    06 abr 2016
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01676637
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene SAWP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 01 jun 1989
    Entregado el 10 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land & buildings situated as southover wells somerset together with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1989Registro de una carga
    • 29 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 jun 1989
    Entregado el 10 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1989Registro de una carga
    • 29 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 26 ene 1989
    Entregado el 14 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a southover wells, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 feb 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 ene 1989
    Entregado el 03 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £420,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H land & buildings situate at southover at wells in the county of somerset.
    Personas con derecho
    • Guardian Assurance PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1989Registro de una carga
    • 29 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 02 mar 1987
    Entregado el 06 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a southern wills, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 mar 1987Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 29 ene 1987
    Entregado el 06 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1987Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 30 dic 1986
    Entregado el 20 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1987Registro de una carga
    Charge over bookdebts
    Creado el 14 mar 1985
    Entregado el 22 mar 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be owing the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 mar 1985Registro de una carga
    Fixed and floating charge
    Creado el 27 ago 1982
    Entregado el 03 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts, floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1982Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0