SAWP LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SAWP LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01565544 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SAWP LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SAWP LIMITED?
Dirección de la sede social | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SAWP LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SOUTHERN AND WESTERN PRESS LIMITED | 15 nov 1984 | 15 nov 1984 |
SURREY PROPERTY MAIL LIMITED | 02 jun 1981 | 02 jun 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SAWP LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 25 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SAWP LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 28 mar 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 26 nov 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Simon Alton Westrop el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Henry Kennedy Faure Walker el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY el 11 dic 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Davidson como director el 11 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Henry Kennedy Faure Walker como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SAWP LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Secretario | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Secretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Finance Director | 69320190004 | ||||
BLACKNELL, David | Secretario | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
BRESNARK, Lawrence | Secretario | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
GLASS, Josephine Mary | Secretario | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Secretario | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
TOWNSEND, John Arthur | Secretario | 36 Guithavon Road CM8 1HD Witham Essex | British | 7332310001 | ||||||
AIKEN, Iain William | Director | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
BLACKNELL, David | Director | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | Company Secretary | 7332320001 | |||||
BRESNARK, Lawrence | Director | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
BROWN, James Thomson | Director | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Exec | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Director | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Newspaper Publisher | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Director | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
GRAHAM, John Stuart | Director | 10 Hatley Close Friern Barnet N11 3LN London | British | Chartered Accountant | 72224100001 | |||||
HARRIS, Philip James | Director | 18 Palairet Close BA15 1US Bradford On Avon Wiltshire | British | Newspaper Director | 26617980001 | |||||
MATTHEWS, David John | Director | 17 Orwell Drive Keynsham BS18 1QB Bristol Avon | British | Accountant | 26617990001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Director | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Director | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
SKINNER, Peter John | Director | 22 Beresford Gardens SS7 2SA Hadleigh Essex | British | Chartered Accountant | 7332340001 | |||||
STEVENSON, Hew Shannan | Director | 42 Canonbury Square N1 2AW London | British | Newspaper Director | 8030630001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SAWP LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 06 abr 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene SAWP LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creado el 01 jun 1989 Entregado el 10 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a land & buildings situated as southover wells somerset together with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 jun 1989 Entregado el 10 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 26 ene 1989 Entregado el 14 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a southover wells, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 26 ene 1989 Entregado el 03 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £420,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H land & buildings situate at southover at wells in the county of somerset. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 02 mar 1987 Entregado el 06 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a southern wills, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 29 ene 1987 Entregado el 06 feb 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 30 dic 1986 Entregado el 20 ene 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge over bookdebts | Creado el 14 mar 1985 Entregado el 22 mar 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be owing the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 27 ago 1982 Entregado el 03 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book debts and other debts, floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0