OLDCO (NO.1) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OLDCO (NO.1) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01565718 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OLDCO (NO.1) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Old Broad Street EC2N 1AD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SBJ GROUP ADMINISTRATION LIMITED | 20 dic 1990 | 20 dic 1990 |
| W S MOODY HOLDINGS LIMITED | 02 ago 1985 | 02 ago 1985 |
| W.S. MOODY (HOLDINGS) LIMITED | 02 jun 1981 | 02 jun 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 04 dic 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Graham Bobby el 24 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge como director el 14 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Susan Nicola Teale como director el 14 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Harvey como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL, Jeremy Peter | Secretario | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | British | 135642970001 | ||||||
| BOBBY, Christopher Graham | Director | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | 170592990002 | |||||
| TEALE, Susan Nicola | Director | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | 217659080001 | |||||
| BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Secretario | Turret Grove Clapham SW4 0ES London 25 | United Kingdom | 1464480001 | ||||||
| COLE, Simon Lawrence Vernon | Secretario | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 50520880006 | ||||||
| COLE, Simon Lawrence Vernon | Secretario | 10 Clarence Road Wimbledon SW19 8QE London | British | 50520880002 | ||||||
| WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Whitechapel Road E1 1JG London One Hundred Whitechapel | 130133160001 | |||||||
| WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | 100 Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | 68360510001 | |||||||
| ANDERSON, Philip John | Director | 1 Warmans Close Bawburgh NR9 3JB Norwich Norfolk | Uk | British | 79136250001 | |||||
| BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 1464480002 | ||||||
| BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Director | Turret Grove Clapham SW4 0ES London 25 | England | United Kingdom | 1464480001 | |||||
| BODEN, George | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | United Kingdom | British | 149286650001 | |||||
| BODEN, George | Director | Flat 4 4 Onslow Gardens SW7 3LX London | British | 2338580002 | ||||||
| CLARK, James Albert | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 6514930003 | ||||||
| COLE, Simon Lawrence Vernon | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 50520880006 | ||||||
| GRAY, Peter | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 2358790002 | ||||||
| HARVEY, Graham | Director | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | 168974600001 | |||||
| HOLT, Antony Vincent | Director | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | 190351400001 | |||||
| KEYS, Anthony James | Director | 63 Pont Street SW1X 0BD London | United Kingdom | British | 2338570001 | |||||
| POUPART-LAFARGE, Bertrand | Director | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | French | 174977050001 | |||||
| STEEPLES, Howard | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 11084310002 | ||||||
| VINTEN, Duncan James Gordon | Director | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 26608710003 | ||||||
| WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Whitechapel Road E1 1JG London One Hundred Whitechapel | 130132980001 | |||||||
| WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | 100 Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | 68360650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OLDCO (NO.1) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinc Uk Group Limited | 06 abr 2016 | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene OLDCO (NO.1) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 11 jul 2007 Entregado el 18 jul 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed in respect of a mortgage debenture and a composite guarantee both dated 9 june 1999 issued by the company | Creado el 31 dic 2001 Entregado el 10 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 09 jun 1999 Entregado el 19 jun 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 25 nov 1997 Entregado el 05 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The sum of £1,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 46156178 and earmarked by reference to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 14 mar 1986 Entregado el 27 mar 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from keith macdonald smith to the chargee not exceeding £15,000 | |
Breve descripción All moneys from time to time held to yhe credit of the company by national westminster bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the company may now and/or hereafter have with national westminster bank PLC and/or under any deposit receipt. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 04 sept 1985 Entregado el 17 sept 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from P.F. lovelock to the chargee not exceeding £17,500 | |
Breve descripción All moneys from time to time held to the credit of the company (please see doc M12 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 07 ene 1985 Entregado el 21 ene 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from peter frederick lovelock to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All moneys from time to time held to the credit of the company by national westminister bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the co may now or/and hereafter have with national westminsiter bank PLC and/or under any deposit receipt. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0