RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED

RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01566804
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CAPIO HEALTHCARE UK LIMITED05 nov 200105 nov 2001
    COMMUNITY HOSPITALS GROUP LIMITED31 may 198831 may 1988
    COMMUNITY HOSPITALS PLC08 jun 198108 jun 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2006

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 mar 2010

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 abr 2009

    LRESSP

    legacy

    3 páginas88(3)

    legacy

    2 páginas88(2)

    legacy

    1 páginasSH20

    Misceláneos

    11/05/09 reduced from 39363902 to 2 mem of capital
    1 páginasMISC

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium red by £14,554,954 14/04/2009
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginas122

    Resoluciones

    Resolutions
    48 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción del Memorándum de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    £2784335 14/04/2009
    RES14

    legacy

    1 páginas287

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    9 páginas155(6)b

    legacy

    9 páginas155(6)b

    legacy

    9 páginas155(6)b

    legacy

    9 páginas155(6)b

    legacy

    9 páginas155(6)a

    ¿Quiénes son los directivos de RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALE, Andrew Michael
    24 Godwin Way
    Bromham
    MK43 8JH Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    24 Godwin Way
    Bromham
    MK43 8JH Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant78611560001
    MEHTA, Hiten
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    Director
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector78629780001
    WATTS, Jill Margaret
    Shad Thames
    SE1 2YE London
    403 Butlers Wharf 36
    Director
    Shad Thames
    SE1 2YE London
    403 Butlers Wharf 36
    Great BritainBritishDirector162338280001
    CROKER, David Geoffrey
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director62363640001
    MEHTA, Hiten
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    British78629780001
    NEWBERY, Richard Charles William
    25 De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretario
    25 De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    Cambridgeshire
    British40606130001
    NORRIS, David William
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    Secretario
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    BritishAccountant26898620002
    OCOWNELI, Kevin Daniel
    82 Bull Stag Green
    Hatfield
    AL9 5DE St Albans
    Herts
    Secretario
    82 Bull Stag Green
    Hatfield
    AL9 5DE St Albans
    Herts
    British32438330001
    WILLISCROFT, John Edwin
    12 Chapel Fields
    SG18 0ND Biggleswade
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Chapel Fields
    SG18 0ND Biggleswade
    Bedfordshire
    British48428880001
    BATELSON, Per Gunnar
    Kungsgatan 16
    Marstrand
    Se-400 30
    Sweden
    Director
    Kungsgatan 16
    Marstrand
    Se-400 30
    Sweden
    SwedenSwedishDirector181830090001
    BAXENDALE, Raymond
    Burleigh House
    1 The Waits
    PE27 5BY St. Ives
    Cambridgeshire
    Director
    Burleigh House
    1 The Waits
    PE27 5BY St. Ives
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManaging Director76722180001
    BRODEN, Jan Stanley
    Hasttorget 2
    Laholm
    Se 312 30
    Sweden
    Director
    Hasttorget 2
    Laholm
    Se 312 30
    Sweden
    SwedishDirector79016500001
    CARLSON, Per Henrik Staffan
    Ramansgatan 30
    Se-44230 Kungalr
    Sweden
    Director
    Ramansgatan 30
    Se-44230 Kungalr
    Sweden
    SwedishCfo86496780001
    CROKER, David Geoffrey
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    UkBritishFinance Director62363640001
    DEXTER, Alan Michael
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    Director
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    EnglandBritishChairman32438340001
    ELSIGOOD, Timothy James
    8 Beech Drive
    PE9 4EW Ryhall
    Stamford Lincolnshire
    Director
    8 Beech Drive
    PE9 4EW Ryhall
    Stamford Lincolnshire
    BritishManaging Director78191450001
    FRIMAN, Anders
    Tystbergavagen 17
    Enskede
    Se-122 41
    Sweden
    Director
    Tystbergavagen 17
    Enskede
    Se-122 41
    Sweden
    SwedishDirector118687660001
    HEMMING ALLEN, Myra Jennifer
    The Coach House
    19 Church Street
    PE19 5SJ Buckden
    Cambridgeshire
    Director
    The Coach House
    19 Church Street
    PE19 5SJ Buckden
    Cambridgeshire
    BritishDirector-Human Resources73808030001
    HILLIER, David
    73 Klea Avenue
    SW4 9HZ London
    Director
    73 Klea Avenue
    SW4 9HZ London
    BritishCeo117837850002
    HODGSON, Robin Granville, Lord
    15 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    Director
    15 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    EnglandBritishCompany Director78181310001
    HOKFELT, Paul
    4 Ch Prcs-Courts
    Vesenaz
    Ch-1222
    Switzerland
    Director
    4 Ch Prcs-Courts
    Vesenaz
    Ch-1222
    Switzerland
    SwedishCeo118687560001
    MANN, Thomas Joseph, Dr
    42 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    42 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive95641850001
    MATTSSON, Ulf Sven Ivar
    Gotabergsgatan 22
    Goteborg
    Se-411 34
    Sweden
    Director
    Gotabergsgatan 22
    Goteborg
    Se-411 34
    Sweden
    SwedeCeo113105270001
    MCCUTHCHEON, Ian Crawford
    Saplings 1 Spicers Field
    KT22 0UT Oxshott
    Surrey
    Director
    Saplings 1 Spicers Field
    KT22 0UT Oxshott
    Surrey
    BritishDirector32438380001
    ODONOGHUE, Neil
    Flat 14 20 Queen Annes Terrace
    W1N London
    Director
    Flat 14 20 Queen Annes Terrace
    W1N London
    IrishConsultant Urological Surgeon32438390001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Director
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive11755290002
    PRENTICE, Oliver John
    Mill Farm Cottage
    Westbury
    NN13 5JS Brackley
    Northamptonshire
    Director
    Mill Farm Cottage
    Westbury
    NN13 5JS Brackley
    Northamptonshire
    BritishManaging Director-Continuing C28269820003
    RUDDELL, Michael Frith
    Pelham Lodge Clifton Lane
    Ruddington
    NG11 6AB Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Pelham Lodge Clifton Lane
    Ruddington
    NG11 6AB Nottingham
    Nottinghamshire
    IrishDirector9723520001
    SIMONDS-GOODING, Anthony James Joseph
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    Director
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    BritishCompany Director50867110002
    SJOSTEDT, Dwight
    68j Randolphs Avenue
    Little Venice
    W9 London
    Director
    68j Randolphs Avenue
    Little Venice
    W9 London
    SwedishChief Executive105414850001
    STOCK, Linda
    Rose Cottage
    Aston Ingham Road Kilcot
    GL18 1NS Newent
    Gloucestershire
    Director
    Rose Cottage
    Aston Ingham Road Kilcot
    GL18 1NS Newent
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector104973300001
    SVALSTEDT, Carl Martin
    Varpmossevagen 30
    Askim
    Se-436 39
    Sweden
    Director
    Varpmossevagen 30
    Askim
    Se-436 39
    Sweden
    SwedishDirector76029430001
    THOMPSON, Peter Anthony, Sir
    The Mill House
    MK16 8ER Newport Pagnell
    Bucks
    Director
    The Mill House
    MK16 8ER Newport Pagnell
    Bucks
    EnglandBritishChairman809410001
    TINCKHAM, Loretta Fay
    Lion House
    Great Bircham
    PE31 6RJ King's Lynn
    Norfolk
    Director
    Lion House
    Great Bircham
    PE31 6RJ King's Lynn
    Norfolk
    BritishExecutive Director95319780001
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Director
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritishDirector82667700001

    ¿Tiene RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 24 may 2007
    Entregado el 13 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the right, title and interest in and to each of the following assets being the real property; and the investments; and by way of first floating charge all present and future assets and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee)
    Transacciones
    • 13 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge between the company and deutsche bank ag london as security agent for itself and the finance parties (the security agent)
    Creado el 21 sept 2001
    Entregado el 09 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the security agent under or in respect of the senior facility agreement dated 26TH april 2001 the guarantee given by the chargor under the facility agreement or the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charge all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London
    Transacciones
    • 09 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares between the chargor and deutsche bank ag london as security agent for itself and for and on behalf of the finance parties (the security agent)
    Creado el 21 sept 2001
    Entregado el 09 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All and any amounts of any kind now or in the future due payable by the chargor to any of the finance parties under or in connection with the facility agreement dated 26TH april 2001 (as amended) or the guarantee given by the chargor under the facility agreement or the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the original securities and any other which the chargor may substitute for all or any of the original securities and all other securities rights moneys (including without limitation dividends) and property which may be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London
    Transacciones
    • 09 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 11 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note guarantee dated 3 february 1998
    Breve descripción
    The sum of £2,400,ooo together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8910219 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over deposit account and counterpart
    Creado el 05 ene 1994
    Entregado el 13 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies paid by the company into the charged account which may be released to the chargee under the terms of the agreement for lease
    Breve descripción
    The interest bearing sterling deposit account number 51813556 at national westminster bank PLC 81 high street bedford.
    Personas con derecho
    • Chg Homes PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 abr 2009Inicio de la liquidación
    23 jun 2010Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew John Waghorn
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Berkshire
    Profesional
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Berkshire
    David William Tann
    Nortons Recovery Limited
    Highlands House
    RG7 1NT Basingstoke Road
    Spencers Wood Reading
    Profesional
    Nortons Recovery Limited
    Highlands House
    RG7 1NT Basingstoke Road
    Spencers Wood Reading

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0