BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01571833
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TROLHURST LIMITED01 jul 198101 jul 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 abr 2016

    LRESSP
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 abr 2016

    LRESSP

    Restauración por orden judicial - anteriormente en liquidación voluntaria de socios

    2 páginasREST-MVL

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Nombramiento de Mr Andrew William Hodges como director el 30 jun 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nicola Margaret Carroll como director el 30 jun 2016

    1 páginasTM01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 feb 2016

    Estado de capital el 05 feb 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Nicola Margaret Carroll el 09 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 feb 2015

    Estado de capital el 17 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 feb 2014

    Estado de capital el 27 feb 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Steven Buck como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Centrica Directors Limited como director

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Nicola Margaret Carroll como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew Bateman como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Secretario corporativo
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    71532760003
    HODGES, Andrew William
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro3844287
    146695600001
    FREUDMANN, Anthony
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    Secretario
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    British43335320001
    WHEATLEY, Trevor Neil Pearse
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    British34588420002
    ARIF, Louise
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    Director
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    British36425190002
    BASSIS, Anne Elizabeth
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    Director
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    United KingdomAmerican/British112345920001
    BATEMAN, Matthew James
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish138280510002
    BOWTELL, John Paul Maurice
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    Director
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    British82969690001
    BUCK, Steven John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish96292880001
    CARROLL, Nicola
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish278861170001
    COLLIER, Edward Arthur Yarlet
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    Director
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    British72213650001
    CORBETT, Michael Anthony
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    Director
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    British7008160003
    CORDINGLEY, Anthony Clive
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    Director
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    British7008170001
    DUNN, David Young
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    Director
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    British38982880001
    FARRAR, John Trueman
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    Director
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    British34540860001
    FARROW, Dennis
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    Director
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    British10910860001
    FLETT, Alan Douglas
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    Director
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish93037840001
    HAYWARD, Ian Charles
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    Director
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    British79564240001
    KENDLE, David Philip
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    Director
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish95977510001
    KENYON, Rodney Frank
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    Director
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    EnglandBritish62258710001
    LAIRD, James
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    Director
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    British34535330001
    LENHAM, Stephen
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    Director
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    British7008190004
    MAXEY, Clement Leslie
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    Director
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    British37195980001
    PINCHIN, Terence Rodney
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    Director
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    British65159820001
    RAY, John Albert
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    Director
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish104536620001
    SHAW, Daniel Rankin
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    Director
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    ScotlandBritish7008210001
    SHEARS, John Nicholas
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    Director
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    BritishBritish61771310001
    STERN, Christopher John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    EnglandEnglish55825790001
    TURNER, Moira Lynne
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82549950002
    UZIELLI, Michael Robin
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Director
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    British107591700002

    ¿Tiene BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 15 nov 1999
    Entregado el 26 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 26 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 27 sept 1999
    Entregado el 30 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 30 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 02 jul 1999
    Entregado el 10 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 02 jul 1999
    Entregado el 10 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creado el 05 nov 1998
    Entregado el 14 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead
    Breve descripción
    All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof.
    Personas con derecho
    • Renbrook Limited
    Transacciones
    • 14 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 14 oct 1996
    Entregado el 30 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed
    Breve descripción
    Rent deposit of £1300.
    Personas con derecho
    • Renbrook Limited
    Transacciones
    • 30 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 14 mar 1996
    Entregado el 16 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 16 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creado el 17 ene 1996
    Entregado el 23 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Griffin Factors Limited
    Transacciones
    • 23 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 dic 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £225,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1.
    Personas con derecho
    • Slark Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ene 1995
    Entregado el 17 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 17 feb 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 sept 1994
    Entregado el 04 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 04 feb 1992
    Entregado el 08 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82
    Breve descripción
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 nov 1986
    Entregado el 19 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    115 marsham court marsham street london.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1986Registro de una carga
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 18 ene 1982
    Entregado el 21 ene 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ene 1982Registro de una carga
    • 04 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 abr 2016Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0