COBLANDS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOBLANDS LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01573886
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COBLANDS LTD?

    • Comercio al por mayor de flores y plantas (46220) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra COBLANDS LTD?

    Dirección de la sede social
    The Stables Duxbury Park
    Duxbury Hall Road
    PR7 4AT Chorley
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COBLANDS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COBLANDS NURSERIES LTD21 jun 200421 jun 2004
    COBLANDS T. S. LIMITED13 jul 198113 jul 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COBLANDS LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COBLANDS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    2 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge Preston PR5 6BY a The Stables Duxbury Park Duxbury Hall Road Chorley PR7 4AT el 15 jul 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mike John Quayle como director el 02 ene 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony William Hewitt como director el 02 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Craig Peter Newcombe como director el 10 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Paul Bennett como director el 22 sept 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Anthony William Hewitt como director el 22 sept 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Charles Corcoran como director el 31 mar 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de COBLANDS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    QUAYLE, Mike John
    Duxbury Park
    Duxbury Hall Road
    PR7 4AT Chorley
    The Stables
    England
    Director
    Duxbury Park
    Duxbury Hall Road
    PR7 4AT Chorley
    The Stables
    England
    EnglandBritishDirector95332960002
    ARMSTRONG, Catherine
    3 St Andrews Road
    RG9 1HS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    3 St Andrews Road
    RG9 1HS Henley On Thames
    Oxfordshire
    British94314590001
    BITHELL, Charles Peter
    The Hawthorns
    78 The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Secretario
    The Hawthorns
    78 The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    BritishDirector70732940003
    BOWMAN, Terence Patrick Edward
    Apartment 11 Ryburn
    Barkisland Mill Beestonley Lane
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    Secretario
    Apartment 11 Ryburn
    Barkisland Mill Beestonley Lane
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    BritishAccountant127543040001
    BOWMAN, Terence Patrick Edward
    Apartment 11 Ryburn
    Barkisland Mill Beestonley Lane
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    Secretario
    Apartment 11 Ryburn
    Barkisland Mill Beestonley Lane
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    BritishFinance Director127543040001
    BURNS, Norah Jane Jacinta
    78 Kilworth Drive
    Lostock
    BL6 4RL Bolton
    Lancashire
    Secretario
    78 Kilworth Drive
    Lostock
    BL6 4RL Bolton
    Lancashire
    BritishSolicitor114059940002
    FRY, Graham Roy
    3 Elim Cottages
    Busty Lane
    TN15 9HP Ightham
    Kent
    Secretario
    3 Elim Cottages
    Busty Lane
    TN15 9HP Ightham
    Kent
    New ZealandAccountant46000990002
    ROSLING, Heather Anne
    Green Walk
    Gatley
    SK8 4BW Stockport
    42
    Cheshire
    Secretario
    Green Walk
    Gatley
    SK8 4BW Stockport
    42
    Cheshire
    British154885660001
    STOCKDALE, Carolyn
    Beacon View
    Appley Bridge
    WN6 9AJ Wigan
    6
    Lancashire
    Secretario
    Beacon View
    Appley Bridge
    WN6 9AJ Wigan
    6
    Lancashire
    BritishCompany Secretary130249010003
    TURNER, Valerie Ann
    Oaklands Back Lane
    Ightham
    TN15 9AU Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Oaklands Back Lane
    Ightham
    TN15 9AU Sevenoaks
    Kent
    British5506300001
    BENNETT, Andrew Paul
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Director
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    EnglandBritishManaging Director65092820001
    BITHELL, Charles Peter
    The Hawthorns
    78 The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Director
    The Hawthorns
    78 The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    EnglandBritishDirecto70732940003
    BONNER, Gerald
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Director
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    EnglandBritishGeneral Manager181698930001
    BURTON, Richard Harvey
    Copperfields
    Kemsing
    TN15 6QG Sevenoaks
    8
    Kent
    Director
    Copperfields
    Kemsing
    TN15 6QG Sevenoaks
    8
    Kent
    EnglandBritishDirector160604000001
    CORCORAN, Andrew Charles
    Orton Close
    LE7 4XZ Rearsby
    19
    Leicestershire
    Director
    Orton Close
    LE7 4XZ Rearsby
    19
    Leicestershire
    United KingdomBritishManaging Director78818290001
    CRAYFORD, Philip Keith
    120 The Street
    Boughton
    ME13 9AP Kent
    Director
    120 The Street
    Boughton
    ME13 9AP Kent
    BritishAccountant97716610001
    FRY, Graham Roy
    3 Elim Cottages
    Busty Lane
    TN15 9HP Ightham
    Kent
    Director
    3 Elim Cottages
    Busty Lane
    TN15 9HP Ightham
    Kent
    New ZealandAccountant46000990002
    HAWKINS, Peter
    Old Chimneys Sparrows Green
    TN5 6UG Wadhurst
    East Sussex
    Director
    Old Chimneys Sparrows Green
    TN5 6UG Wadhurst
    East Sussex
    BritishAccountant5721390001
    HEWITT, Anthony William
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Director
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    EnglandBritishDirector130793730001
    HEWITT, Anthony William
    Alston Lane
    Longridge
    PR3 3BN Preston
    Alston Old Hall
    Lancashire
    Director
    Alston Lane
    Longridge
    PR3 3BN Preston
    Alston Old Hall
    Lancashire
    EnglandBritishDirector130793730001
    LANE, Christopher Gilbert
    The Granary Callaways Lane
    Newington
    ME9 7LU Sittingbourne
    Kent
    Director
    The Granary Callaways Lane
    Newington
    ME9 7LU Sittingbourne
    Kent
    EnglandBritishPlant Nursery94823740001
    NEWCOMBE, Craig Peter
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Director
    Parkwood House, Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    EnglandBritishFinance Director132475450003
    NG, Nadine Loon Angela
    Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Parkwood House
    Lancashire
    Director
    Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Parkwood House
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director28959860001
    NG, Nadine Loon Angela
    1 Lumwood
    Smithills
    BL1 6TZ Bolton
    Lancashire
    Director
    1 Lumwood
    Smithills
    BL1 6TZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector28959860001
    TEMPLE-HEALD, Nicholas
    The Downe Arms
    Church Lane
    YO25 5XD Little Driffield
    East Yorkshire
    Director
    The Downe Arms
    Church Lane
    YO25 5XD Little Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritishDirector74074550002
    TRICE, Richard Geoffrey
    202 High Street
    Rainham
    Gillingham
    Kent
    Director
    202 High Street
    Rainham
    Gillingham
    Kent
    BritishEngine Fitter5721400001
    TURNER, Geoffrey Reginald
    Old Orchard
    Calstock Road
    PL18 9AA Gunnislake
    Cornwall
    Director
    Old Orchard
    Calstock Road
    PL18 9AA Gunnislake
    Cornwall
    EnglandBritishHorticulturalist94823750001
    VICCARS, Colin Thomas
    Four Winds Chafford Lane
    Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Four Winds Chafford Lane
    Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishHorticulturalist5721410002
    WEST, Geoffrey Fredric
    Angrove Cottage
    Goldsmiths Avenue
    TN6 1RH Crowborough
    East Sussex
    Director
    Angrove Cottage
    Goldsmiths Avenue
    TN6 1RH Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritishHorticulturalist5506320001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de COBLANDS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Parkwood House
    England
    06 abr 2016
    Berkeley Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6BY Preston
    Parkwood House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalThe Companies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro0989758
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene COBLANDS LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 ago 1987
    Entregado el 11 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 sept 1987Registro de una carga
    • 12 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Further guarantee & debenture
    Creado el 19 abr 1982
    Entregado el 26 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts buildings fixtures, fixed plant & machinery uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank LTD
    Transacciones
    • 26 abr 1982Registro de una carga
    • 12 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0