COBLANDS LTD
Visión general
Nombre de la empresa | COBLANDS LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01573886 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COBLANDS LTD?
- Comercio al por mayor de flores y plantas (46220) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra COBLANDS LTD?
Dirección de la sede social | The Stables Duxbury Park Duxbury Hall Road PR7 4AT Chorley England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COBLANDS LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
COBLANDS NURSERIES LTD | 21 jun 2004 | 21 jun 2004 |
COBLANDS T. S. LIMITED | 13 jul 1981 | 13 jul 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COBLANDS LTD?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COBLANDS LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge Preston PR5 6BY a The Stables Duxbury Park Duxbury Hall Road Chorley PR7 4AT el 15 jul 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Mike John Quayle como director el 02 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony William Hewitt como director el 02 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Craig Peter Newcombe como director el 10 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Paul Bennett como director el 22 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Anthony William Hewitt como director el 22 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Andrew Charles Corcoran como director el 31 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COBLANDS LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAYLE, Mike John | Director | Duxbury Park Duxbury Hall Road PR7 4AT Chorley The Stables England | England | British | Director | 95332960002 | ||||
ARMSTRONG, Catherine | Secretario | 3 St Andrews Road RG9 1HS Henley On Thames Oxfordshire | British | 94314590001 | ||||||
BITHELL, Charles Peter | Secretario | The Hawthorns 78 The Common Parbold WN8 7EA Wigan Lancashire | British | Director | 70732940003 | |||||
BOWMAN, Terence Patrick Edward | Secretario | Apartment 11 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane HX4 0AG Halifax West Yorkshire | British | Accountant | 127543040001 | |||||
BOWMAN, Terence Patrick Edward | Secretario | Apartment 11 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane HX4 0AG Halifax West Yorkshire | British | Finance Director | 127543040001 | |||||
BURNS, Norah Jane Jacinta | Secretario | 78 Kilworth Drive Lostock BL6 4RL Bolton Lancashire | British | Solicitor | 114059940002 | |||||
FRY, Graham Roy | Secretario | 3 Elim Cottages Busty Lane TN15 9HP Ightham Kent | New Zealand | Accountant | 46000990002 | |||||
ROSLING, Heather Anne | Secretario | Green Walk Gatley SK8 4BW Stockport 42 Cheshire | British | 154885660001 | ||||||
STOCKDALE, Carolyn | Secretario | Beacon View Appley Bridge WN6 9AJ Wigan 6 Lancashire | British | Company Secretary | 130249010003 | |||||
TURNER, Valerie Ann | Secretario | Oaklands Back Lane Ightham TN15 9AU Sevenoaks Kent | British | 5506300001 | ||||||
BENNETT, Andrew Paul | Director | Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston | England | British | Managing Director | 65092820001 | ||||
BITHELL, Charles Peter | Director | The Hawthorns 78 The Common Parbold WN8 7EA Wigan Lancashire | England | British | Directo | 70732940003 | ||||
BONNER, Gerald | Director | Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston | England | British | General Manager | 181698930001 | ||||
BURTON, Richard Harvey | Director | Copperfields Kemsing TN15 6QG Sevenoaks 8 Kent | England | British | Director | 160604000001 | ||||
CORCORAN, Andrew Charles | Director | Orton Close LE7 4XZ Rearsby 19 Leicestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 78818290001 | ||||
CRAYFORD, Philip Keith | Director | 120 The Street Boughton ME13 9AP Kent | British | Accountant | 97716610001 | |||||
FRY, Graham Roy | Director | 3 Elim Cottages Busty Lane TN15 9HP Ightham Kent | New Zealand | Accountant | 46000990002 | |||||
HAWKINS, Peter | Director | Old Chimneys Sparrows Green TN5 6UG Wadhurst East Sussex | British | Accountant | 5721390001 | |||||
HEWITT, Anthony William | Director | Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston | England | British | Director | 130793730001 | ||||
HEWITT, Anthony William | Director | Alston Lane Longridge PR3 3BN Preston Alston Old Hall Lancashire | England | British | Director | 130793730001 | ||||
LANE, Christopher Gilbert | Director | The Granary Callaways Lane Newington ME9 7LU Sittingbourne Kent | England | British | Plant Nursery | 94823740001 | ||||
NEWCOMBE, Craig Peter | Director | Parkwood House, Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston | England | British | Finance Director | 132475450003 | ||||
NG, Nadine Loon Angela | Director | Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston Parkwood House Lancashire | England | British | Company Director | 28959860001 | ||||
NG, Nadine Loon Angela | Director | 1 Lumwood Smithills BL1 6TZ Bolton Lancashire | England | British | Director | 28959860001 | ||||
TEMPLE-HEALD, Nicholas | Director | The Downe Arms Church Lane YO25 5XD Little Driffield East Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 74074550002 | ||||
TRICE, Richard Geoffrey | Director | 202 High Street Rainham Gillingham Kent | British | Engine Fitter | 5721400001 | |||||
TURNER, Geoffrey Reginald | Director | Old Orchard Calstock Road PL18 9AA Gunnislake Cornwall | England | British | Horticulturalist | 94823750001 | ||||
VICCARS, Colin Thomas | Director | Four Winds Chafford Lane Fordcombe TN3 0SH Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Horticulturalist | 5721410002 | ||||
WEST, Geoffrey Fredric | Director | Angrove Cottage Goldsmiths Avenue TN6 1RH Crowborough East Sussex | United Kingdom | British | Horticulturalist | 5506320001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COBLANDS LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Horticulture Limited | 06 abr 2016 | Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston Parkwood House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene COBLANDS LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 27 ago 1987 Entregado el 11 sept 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further guarantee & debenture | Creado el 19 abr 1982 Entregado el 26 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts buildings fixtures, fixed plant & machinery uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0