JOHN GODDEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJOHN GODDEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01580061
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JOHN GODDEN LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra JOHN GODDEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHN GODDEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHN GODDEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginas4.71
    A1HCKOA9

    Domicilio social registrado cambiado de 5th Floor Maple House Mutton Lane Potters Bar Hertfordshire EN6 5BS United Kingdom el 05 ene 2012

    2 páginasAD01
    A0ONG6YI

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70
    A0ONG6Y2

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600
    A0ONG6XU

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 08 dic 2011

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02
    AHUQBZO9

    legacy

    3 páginasMG02
    APBKQZ3M

    legacy

    3 páginasMG02
    AXC5SYJX

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 mar 2011

    Estado de capital el 16 mar 2011

    • Capital: GBP 25,000
    SH01
    X1NLCSHR

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA
    AZ5Y7SCN

    Domicilio social registrado cambiado de Yardley Court 11-12 Frederick Road Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1JD el 21 feb 2011

    1 páginasAD01
    XTP2PRUR

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA
    A5HYANNE

    Cese del nombramiento de Gregoire Bertrand como director

    2 páginasTM01
    AMHAPMMK

    Cese del nombramiento de Gregoire Bertrand como secretario

    2 páginasTM02
    AMHAQMML

    Nombramiento de Neil Michael Croxson como director

    3 páginasAP01
    AMHA8MM3

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    X3YVCIE1

    Cambio de datos del director Mr Gregoire Brendan Bertrand el 01 mar 2010

    2 páginasCH01
    X3YVBIE0

    Cambio de datos del secretario Mr Gregoire Brendan Bertrand el 01 jul 2009

    1 páginasCH03
    X296QIBX

    Cambio de datos del director Mr Gregoire Brendan Bertrand el 01 jul 2009

    1 páginasCH01
    X293UIBY

    Cambio de datos del director Mr Gregoire Brendan Bertrand el 01 jul 2009

    1 páginasCH01
    X28WXIBT

    Cambio de datos del secretario Mr Gregoire Brendan Bertrand el 01 jul 2009

    1 páginasCH03
    X28Y9IB7

    Domicilio social registrado cambiado de Senate House 6-16 Southgate Road Potters Bar Hertfordshire EN6 5DS el 26 feb 2010

    2 páginasAD01
    JZ4EAHRI

    legacy

    3 páginasMG04
    PVCCZFAW

    ¿Quiénes son los directivos de JOHN GODDEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROXSON, Neil Michael
    Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Glendevon House
    Director
    Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Glendevon House
    United KingdomBritishNone96469690003
    LASCHKAR, Henri-Paul
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    Director
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    UkFrenchManaging Director139160640001
    BERTRAND, Gregoire Brendan
    Rue Dumont Valerien
    92 210 Saint Cloud
    20
    Secretario
    Rue Dumont Valerien
    92 210 Saint Cloud
    20
    FrenchChief Financial Officer125806040001
    CROXSON, Neil Michael
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    Secretario
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    BritishChief Financial Officer96469690002
    DE CLERMONT TONNERRE, Bertrand
    6 Rue De La Grange Bateliere
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    Secretario
    6 Rue De La Grange Bateliere
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    FrenchControler75705610001
    DREYFUS, Nicolas
    49 Temple Avenue
    N20 9EL London
    Secretario
    49 Temple Avenue
    N20 9EL London
    FrenchFinance Director90282920001
    LAPPIN, John
    15 The Drive
    IG9 5RB Buckhurst Hill
    Essex
    Secretario
    15 The Drive
    IG9 5RB Buckhurst Hill
    Essex
    BritishFinance Director29589160001
    MASSARD, Pierre Andre
    7 Rue Rouget De Lisle
    St-Germain-En-Laye
    78100
    France
    Secretario
    7 Rue Rouget De Lisle
    St-Germain-En-Laye
    78100
    France
    FrenchFinance Director76014990001
    WARREN, Peter Bernard
    4 Wynbank Close
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    4 Wynbank Close
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    British21822890001
    BAMFORTH, James Richard
    Saling House
    Bardfield Saling
    CM7 5EQ Braintree
    Essex
    Director
    Saling House
    Bardfield Saling
    CM7 5EQ Braintree
    Essex
    BritishManaging Director16229230001
    BERTRAND, Gregoire Brendan
    Rue Du Mont Valerien
    92 210 Saint Cloud
    20
    Director
    Rue Du Mont Valerien
    92 210 Saint Cloud
    20
    FranceFrenchChief Financial Officer125806040002
    BRADBURY, Gwendelen Florence
    38 Lancaster Road
    ST5 1DS Newcastle
    Staffordshire
    Director
    38 Lancaster Road
    ST5 1DS Newcastle
    Staffordshire
    BritishCompany Director49313470001
    BRADBURY, John Cyril
    38 Lancaster Road
    ST5 1DS Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    38 Lancaster Road
    ST5 1DS Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishCompany Director36190930001
    BRODIN, Goran Claes
    57 St Albans Road
    EN5 4LN New Barnet
    Hertfordshire
    Director
    57 St Albans Road
    EN5 4LN New Barnet
    Hertfordshire
    SwedishCompany Director76391670001
    CATEAU, Dominique
    Flat 2
    29 Ferncourt Avenue Hampstead
    NW3 7PG London
    Director
    Flat 2
    29 Ferncourt Avenue Hampstead
    NW3 7PG London
    FrenchManaging Director88248790001
    CROXSON, Neil Michael
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    Director
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    UkBritishChief Financial Officer96469690002
    DE BRABANT, Jeremy Philip
    Flat 7 73 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    Director
    Flat 7 73 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    FrenchManaging Director96469890001
    DERAISON, Gilles
    Hameau De Passy
    48 Rue De Passy
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    Director
    Hameau De Passy
    48 Rue De Passy
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    FrenchEx Vice President75705730001
    GRIFFITHS, Raymond John
    3 Pembroke Drive
    ST5 2JN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    3 Pembroke Drive
    ST5 2JN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishElectrical Engineer110174540001
    HARCOURT, Olive Millicent
    Hamlet Coton In The Clay
    Sudbury
    DE6 5GY Derby
    Derbyshire
    Director
    Hamlet Coton In The Clay
    Sudbury
    DE6 5GY Derby
    Derbyshire
    BritishSales Executive21822920001
    LAPPIN, John
    15 The Drive
    IG9 5RB Buckhurst Hill
    Essex
    Director
    15 The Drive
    IG9 5RB Buckhurst Hill
    Essex
    BritishFinance Director29589160001
    LENOBLE, Pierre Alain
    14 Manor Mansions
    Belsize Grove
    NW3 4NB London
    Director
    14 Manor Mansions
    Belsize Grove
    NW3 4NB London
    FrenchManaging Director67315900001
    MASSARD, Pierre Andre
    7 Rue Rouget De Lisle
    St-Germain-En-Laye
    78100
    France
    Director
    7 Rue Rouget De Lisle
    St-Germain-En-Laye
    78100
    France
    FrenchFinance Director76014990001
    SALMON, Hubert Nicolas
    39 Ovington Street
    SW3 2JA London
    Director
    39 Ovington Street
    SW3 2JA London
    FrenchManaging Director125805830001
    VALENTINY, Marc
    185 Rue De La Pompe
    FOREIGN Paris F 75116
    France
    Director
    185 Rue De La Pompe
    FOREIGN Paris F 75116
    France
    Belgian FrenchDirector84862620001
    WARREN, Peter Bernard
    4 Wynbank Close
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    4 Wynbank Close
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Accountant21822890001

    ¿Tiene JOHN GODDEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge
    Creado el 05 ene 1994
    Entregado el 25 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an invoice discounting agreement
    Breve descripción
    Fixed equitable charge (1) all receivables purchased or unpurchased or purported to be purchased by the security holder from the company pursuant to a discounting agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transacciones
    • 25 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 mar 1992
    Entregado el 16 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land south of plantation road newstead industrial estate stoke-on-trent and the south east of trentham road. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • John Cyril Bradbury
    Transacciones
    • 16 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 jul 1989
    Entregado el 08 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the south side of plantation road, newstead road, newstead industrial estate newstead, stoke on trent staffordshire. Title no sf 206388.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 1989Registro de una carga
    • 09 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 jul 1989
    Entregado el 08 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the south east of trentham road, stoke on trent, staffordshire title no sf 39341.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 1989Registro de una carga
    • 26 nov 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 20 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1983
    Entregado el 03 ene 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H victoria works victoria st hartshell stoke on trent staffs.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1984Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 14 jun 1982
    Entregado el 17 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charges over undertaking and all property including victoria works, victoria st, hartshill, stoke-on-trent and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments, stock exchange investments & cash with all buildings, fixture s (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 17 jun 1982Registro de una carga
    • 06 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 jun 1982
    Entregado el 11 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, books debts & uncalled capital with all buildings, trade & other fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1982Registro de una carga
    • 06 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 06 jul 1992Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 nov 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 09 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene JOHN GODDEN LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 dic 2011Inicio de la liquidación
    18 dic 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Julian Pitts
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Profesional
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Profesional
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0