CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01580284 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sean William Lowther el 17 ene 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 25 Gresham Street London EC2V 7HN | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 25 Gresham Street London EC2V 7HN | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ a 1 More London Place London SE1 2AF el 28 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mrs Karen Joanne Mckay como secretario el 23 nov 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan David Yuille como secretario el 15 nov 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ronald Frank Cameron Taylor como director el 09 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Mark Parsons como director el 09 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Mcintyre como director el 09 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sean William Lowther como director el 09 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Masson Black como director el 29 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 32 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Andrew Jones como director el 29 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Christopher Steuart Hillman como director el 29 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKAY, Karen Joanne | Secretario | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | 252859150001 | |||||||
| HILLMAN, James Christopher Steuart | Director | Lloyds Banking Group The Mound EH1 1YZ Edinburgh Insurance Division Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 248815750001 | |||||
| LOWTHER, Sean William | Director | 10 Canons Way BS1 5LF Bristol Harbourside England | England | British | 210466940002 | |||||
| MCINTYRE, Richard John | Director | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | United Kingdom | British | 166560180001 | |||||
| FOGARTY, Susan Annabel Margaret | Secretario | The Gables Brantham Court CO11 1PP Manningtree Essex | British | 27821960001 | ||||||
| HERD, Catriona Margaret | Secretario | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | British | 150380120001 | ||||||
| MAYER, Sally | Secretario | Dudley Avenue Trinity EH6 4PL Edinburgh 3 | Other | 137324280001 | ||||||
| O'LEARY, Andrew George | Secretario | Paddock House SN15 5EH Great Somerford Wiltshire | British | 10585870001 | ||||||
| VEALE, Peter John | Secretario | 17 Sullivan Road SE11 4UH Kennington London | British | 77902430002 | ||||||
| YUILLE, Alan David | Secretario | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat Lloyds Banking Gro United Kingdom | 174462100001 | |||||||
| ABERCROMBY, Keith William | Director | Somerleaze House Wookey BA5 1JU Wells Somerset | England | British | 109869840001 | |||||
| ALLCHIN, Stephen James | Director | 95 Kingsdown Parade Kingsdown BS6 5UJ Bristol Avon | England | British | 10603150001 | |||||
| BEADLE, William Anthony | Director | 15 Clifford Avenue Middleton LS29 0AS Ilkley West Yorkshire | British | 108531920001 | ||||||
| BLACK, James Masson | Director | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | United Kingdom | British | 172334880001 | |||||
| BOYLE, David Spencer | Director | The Dower House Heythrop OX7 5TL Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 74476830003 | |||||
| BRYSON, Norval Mackenzie, Dr | Director | Lloyds Banking Group The Mound EH1 1YZ Edinburgh Insurance Division Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 344790003 | |||||
| CAULFIELD, Felix Bernard | Director | 53 Tybenham Road Merton Park SW19 3LB London | Irish | 10603160001 | ||||||
| CHRISTOPHERS, Michael | Director | Melville Avenue CR2 7HY South Croydon 14d Surrey | United Kingdom | British | 56738180005 | |||||
| COLSELL, Steven James | Director | Limes House Bytham Road Ogbourne St George SN8 1TD Marlborough Wiltshire | England | British | 101387770001 | |||||
| CORLEY, Roger David | Director | 51 Middleway NW11 6SH London | United Kingdom | British | 9638650001 | |||||
| DAWSON, Joanne | Director | The Mound EH1 1YZ Edinburgh | British | 112053530003 | ||||||
| DEAKIN, Michael John | Director | Northlands Priory Road Hintlesham IP8 3NX Ipswich | British | 43392230002 | ||||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | 16 Langcliffe Avenue HG2 8JQ Harrogate North Yorkshire | Uk | British | 101508990001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | 16 Langcliffe Avenue HG2 8JQ Harrogate North Yorkshire | Uk | British | 101508990001 | |||||
| DUFFIN, Brian James | Director | 8 Craigleith View EH4 3JZ Edinburgh | Scotland | British | 45750300001 | |||||
| EDWARDS, John Stephen | Director | Ebbor House Wookey Hole BA5 1AY Wells Somerset | British | 143155400001 | ||||||
| FERGUSON, Duncan George Robin | Director | Clive Wood Farm Clive SY4 5PR Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 144264940001 | |||||
| FERRANS, Douglas | Director | 9 Lochbroom Drive Newton Mearns G77 5DY Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1166720002 | |||||
| GALE, Patrick Nigel Christopher | Director | Mallams 62 High Street OX14 4EJ Milton Oxfordshire | England | British | 149359970001 | |||||
| GOFORD, Jeremy | Director | Clapham Common West Side SW4 9AR London 45 | United Kingdom | British | 106521140001 | |||||
| GUARD, Eric Nigel | Director | 15 Sandridgebury Lane AL3 6DD St Albans Herts | United Kingdom | British | 99461590001 | |||||
| HAMILTON, Michael | Director | 23 Clarence Terrace NW1 4RD London | British | 103460530001 | ||||||
| HIEW, John Patrick | Director | Greenlands Farm Little London, Oakhill BA3 5AZ Bath | United Kingdom | British | 80793040001 | |||||
| HODKINSON, Phil Andrew | Director | Lynden Manor Langworthy Lane SL6 2HH Holyport Berkshire | England | British | 165622070001 | |||||
| HODSON, Eric William | Director | Court House Church Road Bitton BS15 6LJ Bristol Avon | British | 14778700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Widows Limited | 06 abr 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A standard security which was presented for registration in scotland on 11 august 2003 and | Creado el 30 jul 2004 Entregado el 14 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Sites V1, V2, V3 and V4 kirkton campus livingston t/n wln 30390, 30391, 30392 and 30393. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0