WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED

WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01580744
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WESTMINSTER HEALTH CARE HOLDINGS PLC16 oct 199216 oct 1992
    NME (UK) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    MILVERSTEAD LIMITED17 ago 198117 ago 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 015807440009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 015807440010

    1 páginasMR04

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 oct 2018

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share prem and other reseves cancelled 15/10/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jon Hather como director el 14 oct 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Patrick O'reilly como secretario el 03 abr 2017

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Michael Patrick O'reilly como director el 03 abr 2017

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Dr Dr Mark Antony Hazlewood el 27 feb 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Dr Pete Calveley el 28 feb 2017

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Suite 304, Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour London SW10 0XF a 3rd Floor the Aspect Finsbury Square London EC2A 1AS el 08 mar 2017

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Ian Portal como secretario el 05 oct 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ian John Portal como director el 05 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    15 páginasAA

    Registro de la carga 015807440010, creada el 01 ago 2016

    46 páginasMR01

    Cambio de datos del director Mr Ian John Portal el 01 ago 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Ian Portal el 01 ago 2016

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    O'REILLY, Michael Patrick
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Secretario
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    230771860001
    CALVELEY, Pete
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish188462950001
    HAZLEWOOD, Dr Mark Antony, Dr
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish186525550001
    O'REILLY, Michael Patrick
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish40241900001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYTER, Alan Henry
    Birchlands
    Milland
    GU30 7LU Liphook
    Hants
    Secretario
    Birchlands
    Milland
    GU30 7LU Liphook
    Hants
    British212050001
    O'CONNELL, Kevin Daniel
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    Secretario
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    English15336730002
    PORTAL, Ian
    Third Floor, Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 304,
    United Kingdom
    Secretario
    Third Floor, Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 304,
    United Kingdom
    165321850001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Secretario
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    British58759290001
    ARGENT, Malcolm, Mr.
    Chestnuts
    Fryerning Lane Fryerning
    CM4 0DF Ingatestone
    Essex
    Director
    Chestnuts
    Fryerning Lane Fryerning
    CM4 0DF Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish32104000002
    BRADFORD, Martin Major, Mr.
    10 Edenhurst Avenue
    SW6 3PB London
    Director
    10 Edenhurst Avenue
    SW6 3PB London
    EnglandBritish9565360001
    CARTER, Patrick Robert, Lord
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    Director
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    United KingdomBritish6338850001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish97755760001
    EASTERMAN, Philip Harry
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    British63476990001
    FRASER, John Stewart
    The Lodge Forest Place
    Waldron
    TN21 0TG Heathfield
    East Sussex
    Director
    The Lodge Forest Place
    Waldron
    TN21 0TG Heathfield
    East Sussex
    Australian2040370008
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish68848420006
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Director
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    LOCKHART, John William
    The Old Vicarage
    Furneux Pelham
    SG9 0LD Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    The Old Vicarage
    Furneux Pelham
    SG9 0LD Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish83102020001
    MAYEUX, David Russell
    11798 E Pradera Road
    Camarillo
    California 93102
    Usa
    Director
    11798 E Pradera Road
    Camarillo
    California 93102
    Usa
    Usa33851390001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Director
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MITCHELL, Nick
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    Director
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    Englsih92869540001
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish44895330007
    PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    Director
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    British63915280001
    PHIPPEN, Kent William
    35 Singleton Scarp
    Woodside Park
    N12 7AR London
    Director
    35 Singleton Scarp
    Woodside Park
    N12 7AR London
    American36778230001
    PORTAL, Ian John
    Third Floor, Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 304,
    United Kingdom
    Director
    Third Floor, Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 304,
    United Kingdom
    United KingdomBritish165696110001
    POWERS, Marcus Eugene
    2700 Colorado Avenue
    FOREIGN Santa Monica
    California
    Usa
    Director
    2700 Colorado Avenue
    FOREIGN Santa Monica
    California
    Usa
    American10334030001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Director
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    EnglandBritish58759290001
    SCOTT, Iain John Gosman
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    Director
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish40335260002
    SILVER, Richard Barnett
    11755 Montana Avenue
    Los Angeles
    California
    Usa
    Director
    11755 Montana Avenue
    Los Angeles
    California
    Usa
    Usa33851400001
    STREET, Timothy William
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Director
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Australian91455710001
    TYLER JR, Sidney Frederick
    969 S Madison Avenue
    Pasadena
    California 91106
    Usa
    Director
    969 S Madison Avenue
    Pasadena
    California 91106
    Usa
    Usa33851380001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Director
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritish73750450005

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Aspect
    Finsbury Square
    EC2A 1AS London
    3rd Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03738097
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 ago 2016
    Entregado el 08 ago 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    • 19 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 05 oct 2013
    Entregado el 10 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 19 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 dic 2012
    Entregado el 19 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transacciones
    • 19 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 22 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Amendment deed
    Creado el 27 oct 2006
    Entregado el 08 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company as junior creditor has undertaken that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities: in each case the junior creditor concerned shall hold the same upon trust for the security trustee and will promptly pay the same to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Opco debenture accession deed
    Creado el 04 ago 2006
    Entregado el 04 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 04 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An intercreditor and subordination agreement
    Creado el 13 jul 2006
    Entregado el 25 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 25 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security accession deed
    Creado el 06 dic 2004
    Entregado el 17 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 03 jul 2000
    Entregado el 06 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property knowb as lower ground, ground and first floors keats house st thomas street new city court
    Breve descripción
    The deposit of £41,250 and value added tax thereon.
    Personas con derecho
    • Corfield Properties Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 mar 1993
    Entregado el 18 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 19TH february 1993 and this charge
    Breve descripción
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 18 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0