MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01581264 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Dirección de la sede social | 3rd Floor 161 Marsh Wall E14 9AP London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DEARWILD LIMITED | 19 ago 1981 | 19 ago 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Marcus Alvin Rich como director el 26 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 015812640005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 abr 2020
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Rachel Addison como director el 27 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen John May como director el 31 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Sapphire Topco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 mar 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England a 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP el 23 abr 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 015812640005, creada el 05 abr 2018 | 65 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Susana D'emic como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Lauren Ezrol Klein como secretario el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Susana D'emic como director el 07 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jeffrey John Bairstow como director el 07 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Lloyd Meredith como director el 31 may 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDISON, Rachel Bernadette | Director | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| GARVEY, Richard Thomas | Secretario | 31 Clarence Crescent DA14 4DG Sidcup Kent | British | 17057340001 | ||||||
| GORE, John Francis | Secretario | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secretario | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCBRIDE, Donald John | Secretario | 277 Cannon Hill Lane Raynes Park SW20 9DB London | British | 1665830001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secretario | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Secretario | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secretario | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ALEY, William Robert | Director | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ASHELFORD, John Leonard | Director | Kestrel Lodge Courtlands London Road TN10 3DA Tonbridge Kent | England | British | 1665250001 | |||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Director | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Director | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Director | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Director | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United States | American | 265525580001 | |||||
| EVANS, Richard John | Director | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Director | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| GARVEY, Richard Thomas | Director | 31 Clarence Crescent DA14 4DG Sidcup Kent | British | 17057340001 | ||||||
| MAIR, Denise Margaret | Director | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Director | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Director | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MCBRIDE, Donald John | Director | 277 Cannon Hill Lane Raynes Park SW20 9DB London | British | 1665830001 | ||||||
| MELLON, John Benedict | Director | Westward House 7 Hayes Lane CR8 5LE Kenley Surrey | British | 35523050001 | ||||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| OAKLEY, William Morrell | Director | Becketts Croft Malling Road ME18 5AR Teston Maidstone Kent | British | 18898140002 | ||||||
| PHILBIN, John Nicholas | Director | 30 Airedale Avenue Chiswick W4 2NW London | British | 3098280001 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Director | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Director | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Director | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE)?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire Topco Limited | 15 mar 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Magazine Publishing Holdings Limited | 06 abr 2016 | 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29, Blue Fin Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MAGAZINE PUBLISHING COMPANY LTD(THE) alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 05 abr 2018 Entregado el 11 abr 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Please see instrument for further details. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 dic 1985 Entregado el 20 dic 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 17 ago 1983 Entregado el 19 ago 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of set-off | Creado el 26 ago 1982 Entregado el 08 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All or any part of any balance standing to the credit of any account in the name of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture and statutory declaration. | Creado el 02 jun 1982 Entregado el 04 jun 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. Together with all buildings fixtures fixed plant and machinery, all stocks shares and other securities. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0