MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED

MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01591841
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEATHSIDE CATERING LIMITED16 oct 198116 oct 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 ene 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 jul 2019

    11 páginasLIQ03

    Cancelación total de la carga 015918410023

    1 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de Wellington House Cliffe Park Bruntcliffe Road Morley Leeds West Yorkshire LS27 0RY a 4th Floor Allan House 10 John Princes Street London W1G 0AH el 31 jul 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 12 jul 2018

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 015918410022

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 015918410021

    4 páginasMR04

    Registro de la carga 015918410023, creada el 20 dic 2017

    105 páginasMR01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 oct 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 30/10/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Registro de la carga 015918410022, creada el 27 sept 2017

    100 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 015918410020

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Manish Mansukhlal Gudka como director el 27 sept 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Gareth Jones como director el 27 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Purtill como director el 27 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Don Goulding como secretario el 27 sept 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ian Don Goulding como director el 27 sept 2017

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 015918410021, creada el 27 sept 2017

    100 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Director
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    United KingdomBritishCompany Director163227370001
    JONES, Gareth
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Director
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    EnglandBritishChartered Accountant121225470001
    DIGGINES, Susan Catherine
    Rosslyn 17 Eastdowns Road
    Bowdon
    WA14 2LG Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    Rosslyn 17 Eastdowns Road
    Bowdon
    WA14 2LG Altrincham
    Cheshire
    British27914040001
    ELDEKVIST, Lars Stephan
    57 Lickhill Road
    SN11 9DF Calne
    Wiltshire
    Secretario
    57 Lickhill Road
    SN11 9DF Calne
    Wiltshire
    Swedish80108490001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Secretario
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    BritishDirector39828490004
    ROBINSON, Sally Diana
    Wychwood
    Whitehall Lane
    RG8 0TN Checkendon
    Oxfordshire
    Secretario
    Wychwood
    Whitehall Lane
    RG8 0TN Checkendon
    Oxfordshire
    UkDirector90737380001
    ADAMS, Phillip
    9 Cassiobury Drive
    WD17 3AA Watford
    Hertfordshire
    Director
    9 Cassiobury Drive
    WD17 3AA Watford
    Hertfordshire
    BritishDirector90827790001
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Director
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritishDirector130102260001
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Director
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritishHotelier130102260001
    BILLSDON, Stephen Andrew
    Lindendreef 1
    Leefdaal 3061
    Bertem
    Belgium
    Director
    Lindendreef 1
    Leefdaal 3061
    Bertem
    Belgium
    BritishDirector55786710001
    CASTON, Robert Warwick
    Hazeldene Enstone Road
    OX7 3QR Charlbury
    Oxfordshire
    Director
    Hazeldene Enstone Road
    OX7 3QR Charlbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishVice President/Md Holiday Inns (Uk)1311840001
    COLLINGE, Brian
    3 Sandy Lane
    Brinscall
    PR6 8SS Chorley
    Lancashire
    Director
    3 Sandy Lane
    Brinscall
    PR6 8SS Chorley
    Lancashire
    BritishChief Executive27914100002
    COWIE, Graham Michael
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    Director
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director63239220001
    CROSTON, Francis John
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    Director
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    United KingdomBritishCompany Executive65219360003
    DODWELL, Robert
    163 Stanley Road
    SK8 6RF Cheadle Hulme
    Cheshire
    Director
    163 Stanley Road
    SK8 6RF Cheadle Hulme
    Cheshire
    BritishManager84838440001
    ELDEKVIST, Lars Stephan
    57 Lickhill Road
    SN11 9DF Calne
    Wiltshire
    Director
    57 Lickhill Road
    SN11 9DF Calne
    Wiltshire
    United KingdomSwedishDirector80108490001
    FENTON-JONES, Michael Langford
    Eastlea Felix Lane
    TW17 8NN Shepperton
    Middlesex
    Director
    Eastlea Felix Lane
    TW17 8NN Shepperton
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor6081480001
    FORD, James Guy
    Ivy Cottage
    20 Moreton Wood
    TF9 3RX Market Drayton
    Shropshire
    Director
    Ivy Cottage
    20 Moreton Wood
    TF9 3RX Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritishDirector108118850001
    FOXON, Marten
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Director
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    BritishDirector44933010001
    FOXON, Marten
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Director
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    BritishDirector44933010001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Director
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    EnglandBritishDirector39828490044
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Director
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    BritishCompany Director31551670001
    HARTNETT, Thomas
    Dreve De La Meute 4
    B1310 La Hulpe
    Belgium
    Director
    Dreve De La Meute 4
    B1310 La Hulpe
    Belgium
    UsaLawyer49954740001
    HARWOOD-SMITH, Richard
    Kouterstraat 18
    3090 Overijse
    FOREIGN Belgium
    Director
    Kouterstraat 18
    3090 Overijse
    FOREIGN Belgium
    BritishCompany Director37284330001
    HOWARTH, Robert Lever, Councillor
    93 Markland Hill
    BL1 5EQ Bolton
    Greater Manchester
    Director
    93 Markland Hill
    BL1 5EQ Bolton
    Greater Manchester
    BritishCompany Director11262090001
    JONES, Stephen Morris
    5 Lostock Park Drive
    Lostock
    BL6 4AH Bolton
    Lancashire
    Director
    5 Lostock Park Drive
    Lostock
    BL6 4AH Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishLocal Authority Cheif Executiv50234750001
    KNIGHT, Bernard Anthony
    5 Norman Road
    M33 3DF Sale
    Cheshire
    Director
    5 Norman Road
    M33 3DF Sale
    Cheshire
    United KingdomBritishLocal Government41141790001
    LEWIS, William Allan
    16 Dunchurch Road
    Ashton On Mersey
    M33 5SD Sale
    Cheshire
    Director
    16 Dunchurch Road
    Ashton On Mersey
    M33 5SD Sale
    Cheshire
    BritishLocal Authority Chief Executive16600760001
    LINBOURN, John
    Westwood Lenacre Street
    Eastwell
    TN26 1JD Ashford
    Kent
    Director
    Westwood Lenacre Street
    Eastwell
    TN26 1JD Ashford
    Kent
    BritishCompany Director25281880002
    NELSON, Ian Stewart
    9 Vincent Road
    KT11 3JA Cobham
    Surrey
    Director
    9 Vincent Road
    KT11 3JA Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector95906850001
    NELSON, Ian Stewart
    9 Vincent Road
    KT11 3JA Cobham
    Surrey
    Director
    9 Vincent Road
    KT11 3JA Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector95906850001
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Director
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrishDirector7856280001
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Director
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritishAccountant49954790002
    RITSON, Leslie David
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    Director
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    BritishVice President26098610001
    RITSON, Leslie David
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    Director
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director26098610001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Devonshire Point Investment S.A.R.L
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    19 jun 2017
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroLuxembourg
    Autoridad legalLuxembourg
    Lugar de registroRegistre De Commerce Et Des Societes
    Número de registroB185413
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    19 jun 2017
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4683806
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2017
    Entregado el 21 dic 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Not applicable.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 21 dic 2017Registro de una carga (MR01)
    • 05 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 27 sept 2017
    Entregado el 05 oct 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 05 oct 2017Registro de una carga (MR01)
    • 04 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 27 sept 2017
    Entregado el 03 oct 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Not applicable.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 03 oct 2017Registro de una carga (MR01)
    • 04 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 18 abr 2016
    Entregado el 20 abr 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Security Agent)
    Transacciones
    • 20 abr 2016Registro de una carga (MR01)
    • 05 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 29 oct 2014
    Entregado el 06 nov 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Loan Solutions LLP (As Security Agent)
    Transacciones
    • 06 nov 2014Registro de una carga (MR01)
    • 20 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 29 ene 2014
    Entregado el 31 ene 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transacciones
    • 31 ene 2014Registro de una carga (MR01)
    • 26 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A third composite guarantee and debenture
    Creado el 13 nov 2006
    Entregado el 01 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any principal debtor to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a the queens hotel city square leeds t/no wyk 316711, f/h property k/a le meridien warwick kenilworth road warwick t/no wk 283205, f/h property k/a east and west spinneys wooton hill wooton t/no wk 380830 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alchemy Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 16 feb 2005
    Entregado el 03 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee (and/or the hedging counterparty) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 03 mar 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and debenture dated 31 march 2003)
    Creado el 24 feb 2004
    Entregado el 16 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and any other principal debtor to the chargee
    Breve descripción
    L/H property the queens hotel city square leeds t/n WYK316711. F/h property le meridien warwick kenilworth road warwick t/n WK283205. F/h property east and west spinneys wooton hill wooton t/n WK380830 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alchemy Partners Nominees Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 16 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 24 feb 2004
    Entregado el 11 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and any other principal debtor to the chargee
    Breve descripción
    L/H property the queens hotel city square leeds t/n WYK316711. F/h property le meridien warwick kenilworth road warwick t/n WK283205. F/h property east and west spinneys wooton hill wooton t/n WK380830 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alchemy Partners Nominees Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 11 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 feb 2004
    Entregado el 01 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h interest in the midland hotel, lower mosley, manchester t/no LA21577. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 jul 1996
    Entregado el 02 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental debenture
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 06 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and standard chartered bank. Under the terms of the original loan agreement dated 11.4.86 as ammended by the supplemental loan agreement dated 8.4.87 and as further amended by the second supplemental loan agreement dated 19.12.88
    Breve descripción
    By way of first legal motgage l/h land & buildings k/a the midland hotel, lower mosley st, manchester title no la 21577 and/or the proceeds of sale thereof. All buildings fixtures, fixed plant & machinery.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank Limited
    Transacciones
    • 06 ene 1989Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 dic 1987
    Entregado el 21 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 18-11-87
    Breve descripción
    F/H land & buildings k/a the midland hotel at lower mosley street, manchester title no la 21577 and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank Limited
    Transacciones
    • 21 dic 1987Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 abr 1987
    Entregado el 24 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and standard chartered bank pursuant to the terms of the loan agreement dated 11.4.86 as amended by a supplemental loan agreement dated 8.4.87 or any security document executed pursuant thereto.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank Limited
    Transacciones
    • 24 abr 1987Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 abr 1986
    Entregado el 16 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to certain advances under present and future overdraft facilities
    Breve descripción
    Please see doc M24. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank
    Transacciones
    • 16 abr 1986Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 abr 1986
    Entregado el 16 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to a loan agreement dated 11.4.86 or any security documents executed pursuant thereto
    Breve descripción
    F/H land & buildings k/a the midland hotel at lower moseley street manchester title no la 21577 please see doc M23. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transacciones
    • 16 abr 1986Registro de una carga
    • 05 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,440,000
    Breve descripción
    Legal charge over the midland hotel and conference centre, peter st, manchester and all fixtures plant & machinery now or hereafter affixed thereto (title no LA21577) floating charge on all the undertaking & property of midland hotel & conference centre LTD and all other property and assets whatsoever & wheresoever (see M22).
    Personas con derecho
    • Northern Assurance Company Limited.
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,000,000
    Breve descripción
    Legal charge over the midland hotel and conference centre, peter st, manchester and all fixtures plant & machinery now or hereafter affixed thereto (title no LA21577) floating charge on all the undertaking & property of midland hotel & conference centre LTD and all other property and assets whatsoever & wheresoever (see M21).
    Personas con derecho
    • Holiday Inns (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £720,000
    Breve descripción
    Legal charge over the midland hotel and conference centre, peter st, manchester and all fixtures plant & machinery now or hereafter affixed thereto (title no LA21577) floating charge on all the undertaking & property of midland hotel & conference centre LTD and all other property and assets whatsoever & wheresoever (see M20).
    Personas con derecho
    • Northern Assurance Company Limited.
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    • 10 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,560,000
    Breve descripción
    Legal charge over the midland hotel, and conference centre peter st, manchester and all fixtures plant & machinery now or hereafter affixed thereto (title no la 21577) floating charge on all the undertaking and property of midland hotel & conference centre LTD and all other property & assets. Whatsoever & wheresoever. (See M19).
    Personas con derecho
    • Main King Limited
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £780,000
    Breve descripción
    Legal charge over the midland hotel, and conference centre peter st, manchester and all fixtures plant & machinery now or hereafter affixed thereto (title no la 21577) floating charge on all the undertaking and property of midland hotel & conference centre LTD and all other property & assets whatsoever & wheresoever. (See M18).
    Personas con derecho
    • Mainkind Limited
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 09 jun 1983
    Entregado el 17 jun 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of the sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and futture including goodwill, bookdebts and uncalled capital. Legal mortgage over the midland hotel, lower mosley street, manchester title no la 215577 and/or the proceeds of the sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1983Registro de una carga

    ¿Tiene MIDLAND HOTEL AND CONFERENCE CENTRE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 jul 2018Inicio de la liquidación
    01 sept 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Anthony Harry Hyams
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London
    Profesional
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0