CHERITON LEASING LIMITED

CHERITON LEASING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHERITON LEASING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01594155
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHERITON LEASING LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CHERITON LEASING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHERITON LEASING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EXCHANGE LEASING LIMITED26 may 199526 may 1995
    R.B. LEASE FINANCE LIMITED22 sept 198822 sept 1988
    HYDROSPRAY LIMITED29 oct 198129 oct 1981

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHERITON LEASING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHERITON LEASING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Groupe Eurotunnel Se en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 abr 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Emma Cunnington como secretario el 07 sept 2017

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    4 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 jun 2016

    Estado de capital el 09 jun 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Kenneth Glencross Morrison el 01 ene 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Nombramiento de Miss Emma Cunnington como secretario el 25 mar 2015

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jul 2015

    Estado de capital el 03 jul 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Schuller el 12 jun 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 sept 2014

    Estado de capital el 08 sept 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Severine Garnham como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2013

    Estado de capital el 02 jul 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Schuller el 17 ene 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Hugh Murray John Rees como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CHERITON LEASING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORRISON, Kenneth Glencross
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Director
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    EnglandBritish,FrenchDirector105404790001
    REES, Hugh Murray John, M
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Director
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    FranceBritishChartered Accountant172013680001
    SCHULLER, Michael
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Director
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    EnglandIrishTreasurer88022740023
    CUNNINGTON, Emma
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Secretario
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    199207730001
    GARNHAM, Severine Pascale
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    Secretario
    Uk Terminal, Ashford Road
    Folkestone
    CT18 8XX Kent
    156646960001
    GARNHAM, Severine Pascale
    Harefield Avenue
    SM2 7ND Cheam
    67
    Sutton
    United Kingdom
    Secretario
    Harefield Avenue
    SM2 7ND Cheam
    67
    Sutton
    United Kingdom
    FrenchCompany Secretary135449130001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Secretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    LEONARD, David Jack
    6 Milverton Street
    SE11 4AP London
    Secretario
    6 Milverton Street
    SE11 4AP London
    British30168510001
    NIMMO, Mark Alexander
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    Secretario
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    BritishSolicitor33420600001
    CML SECRETARIES LIMITED
    Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    135855110001
    BROWN, Martin Graham
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    Director
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant36168760001
    CARR, Thomas
    Lindisfarne 20 Summerhill Grange
    Lindfield
    RH16 1RQ Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Lindisfarne 20 Summerhill Grange
    Lindfield
    RH16 1RQ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishSales & Marketing Director656980007
    CHANDLER, Stuart Rodwell
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    Director
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    BritishBanker59605380001
    COXON, David
    8 Eastern Terrace
    BN2 1DJ Brighton
    East Sussex
    Director
    8 Eastern Terrace
    BN2 1DJ Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritishBanker121539300001
    DAX, William Airlie
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    Director
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Commercial Officer92201720001
    FARNELL, Adrian Colin
    7 Amaranth Way
    Up Hatherley
    GL51 3YU Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    7 Amaranth Way
    Up Hatherley
    GL51 3YU Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinance Director43015720001
    FREEBOROUGH, Christopher Rupert
    The Malthouse The Green
    Sheepscombe
    GL6 7RG Stroud
    Gloucestershire
    Director
    The Malthouse The Green
    Sheepscombe
    GL6 7RG Stroud
    Gloucestershire
    BritishManager68451360002
    LIENARD, Claude Rene
    Ashford Road
    CT18 8XX Folkestone
    Uk Terminal
    Kent
    England
    Director
    Ashford Road
    CT18 8XX Folkestone
    Uk Terminal
    Kent
    England
    FranceFrenchFinancial Controller73807800004
    MEAGHER, Patrick Joseph
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishInvestment Banker62293450003
    MESNIL, Marc Rene
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    Director
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    FranceInvestment Banker75589840001
    NOULTON, John David
    12 Ladderstile Ride
    KT2 7LP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    12 Ladderstile Ride
    KT2 7LP Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector43725000001
    POINTON, David John
    Honeywood Vicarage Hill
    Petham
    CT4 5RE Canterbury
    Kent
    Director
    Honeywood Vicarage Hill
    Petham
    CT4 5RE Canterbury
    Kent
    BritishDirector58533030001
    ROBSON, Mark David, Mr.
    27 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    27 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant70521890001
    SWEETMAN, Jonathan Michael
    Knole House
    Shaw Green Lane Prestbury
    GL52 3BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Knole House
    Shaw Green Lane Prestbury
    GL52 3BP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishBank Official33029380001
    TAYLOR, Paul Richard
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    Director
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    BritishInvestment Banker75085060001
    TURNER, John Graham
    32 Wingate Road
    W6 0UR London
    Director
    32 Wingate Road
    W6 0UR London
    EnglandBritishBanker35146920001
    WALKER, John Dallow
    27 Thurleigh Road
    SW12 8UB London
    Director
    27 Thurleigh Road
    SW12 8UB London
    BritishLeasing Executive38763500002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHERITON LEASING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Getlink Se
    Rue La Boetie
    Paris
    3
    75008
    France
    06 abr 2016
    Rue La Boetie
    Paris
    3
    75008
    France
    No
    Forma jurídicaEuropean Public Listed Company
    País de registroFrance
    Autoridad legalFrench
    Lugar de registroFrance
    Número de registro483 385 142 Rcs Paris
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CHERITON LEASING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A supplemental deed relating to a loan agreement and debenture dated 29TH june 2001
    Creado el 19 dic 2001
    Entregado el 08 ene 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest of the company in the tripartire agreement dated 23 february 1990 between the company, rolls royce and partners finance limited and rolls-royce PLC, as amended pursuant to a novation and supplemental agreement dated 3 december 1998 between the company, rolls royce and partners finance limited and rolls-royce PLC, as amended by an amendment deed dated 13 july 1999.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 08 ene 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 10 jul 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as exchange leasing limited to the chargee under a loan agreement dated 29 june 2001
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 10 jul 2001Registro de un cargo (395)
    Charge over deposit
    Creado el 18 may 1995
    Entregado el 25 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company in performance of its covenant that it will perform all obligations under a tax account deed dated 18TH may 1995 (as defined therein) to the chargee
    Breve descripción
    All sums from time to time standing to the account of the companys accounts numbers 91001905 and 91001913. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • W & G Industrial Leasing Limited
    Transacciones
    • 25 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0