ARMPLEDGE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ARMPLEDGE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01594306 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ARMPLEDGE LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ARMPLEDGE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARMPLEDGE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DAUPHIN INTERNATIONAL LIMITED | 11 mar 1982 | 11 mar 1982 |
| SILLWING LIMITED | 29 oct 1981 | 29 oct 1981 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ARMPLEDGE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARMPLEDGE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Michael Pryce como director el 25 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cambio de datos del director Gavin Russell el 03 sept 2017 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 06 jun 2017 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Robert Astin como director el 28 mar 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Gavin Russell el 01 dic 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England a Tower Bridge House St Katharine's Way London United Kingdom E1W 1DD el 25 jun 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Bnoms Limited el 09 dic 2015 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Fourth Floor 130 Wilton Road London SW1V 1LQ a 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU el 09 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Andrew Robert Astin como director el 04 ago 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher William Healy como director el 03 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Christopher William Healy como director el 27 abr 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Terence Alan Purvis como director el 27 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Terence Alan Purvis como director el 14 sept 2014 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark David Peters como director el 14 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Gavin Russell como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ARMPLEDGE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNOMS LIMITED | Secretario corporativo | Churchill Place Canary Wharf E14 5HU London 5 England England | 67896020002 | |||||||
| RUSSELL, Gavin | Director | St Katharine's Way E1W 1DD London Tower Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 188396180003 | |||||
| BARTLETT, Paul Eugene | Secretario | Flat 3 Stable Mews Hillside Road AL1 3QR St Albans Hertfordshire | British | 54206450002 | ||||||
| MCDONALD, Ross Edward | Secretario | 5b Vermont Road Upper Norwood SE19 3SR London | British | 44092870001 | ||||||
| PRIEST, Gerard | Secretario | 9 Heightside Avenue Newchurch BB4 9HA Rossendale Lancashire | British | 5896620001 | ||||||
| ASTIN, Andrew Robert | Director | St Katharine's Way E1W 1DD London Tower Bridge House United Kingdom | England | British | 200138200001 | |||||
| BANCROFT, Paul Andrew | Director | 40 Cleveland Road Southwoodford E18 2AL London | England | British | 99625640001 | |||||
| BENNETT, William Keith | Director | 11 Dovedale Drive BB12 8XD Burnley Lancashire | British | 9478320001 | ||||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Director | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BLYTH CURRIE, James Michael | Director | The Old Rectory Upper Woolhampton RG7 5TA Reading Berks | British | 9478340001 | ||||||
| DAUPHIN, Elke Elisabeth | Director | 8 Garten Strasse Offenhausen 91238 Beinurnberg Germany | Germany | German | 48647560001 | |||||
| DAUPHIN, Friedrich Wilhelm | Director | 8 Garten Strasse Offenhausen 91238 Bei Nurnberg Germany | Germany | German | 48647660001 | |||||
| DOWDY, Peter | Director | 58 Cam Wood Fold Clayton Le Woods PR6 7SD Chorley Lancashire | British | 65607580001 | ||||||
| GOLDSMITH, Paul William | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | England | British | 28639100003 | |||||
| GOODMAN, David Hugh | Director | 81 Wentworth Road Golders Green NW11 0RH London | British | 69867560001 | ||||||
| HEALY, Christopher William | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | United Kingdom | British | 197650570001 | |||||
| HOWARD, Claire Lucie Mary | Director | Norsebury Cottage Winchester Road Micheldever SO21 3DG Winchester Hampshire | British | 54519060001 | ||||||
| KNIGHT, Dawn Elizabeth | Director | 2 Temperance Street AL3 4QA St Albans Hertfordshire | British | 19935890001 | ||||||
| LEADILL, Stuart Kenneth | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | United Kingdom | British | 36282500001 | |||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Director | Cob Cottage Shore Road PO18 8HZ Bosham West Sussex | England | British | 34131020003 | |||||
| MCDONALD, Ross Edward | Director | 5b Vermont Road Upper Norwood SE19 3SR London | British | 44092870001 | ||||||
| MCGLONE, Roy Vickers | Director | 11 Pearces Orchard Fairmile RG9 2LF Henley-On-Thames Oxfordshire | British | 45248290001 | ||||||
| MORDLOCK, Charles Anthony | Director | 2 Swallowfields BB1 8NR Blackburn Lancashire | British | 50000830001 | ||||||
| MURRAY, Stuart Fraser | Director | 29 Binden Road W12 9RJ London | British | 675720001 | ||||||
| PEARSON, Christopher Rait O'Neill | Director | Shirley House, 5 West Walks DT1 1RE Dorchester Dorset | British | 60365730001 | ||||||
| PETERS, Mark David | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | United Kingdom | British | 192348430001 | |||||
| PRIEST, Gerard | Director | 9 Heightside Avenue Newchurch BB4 9HA Rossendale Lancashire | British | 5896620001 | ||||||
| PRYCE, Colin Michael | Director | St Katharine's Way E1W 1DD London Tower Bridge House United Kingdom | England | British,Jamaican | 67971010001 | |||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | United Kingdom | British | 7901050001 | |||||
| SIMPSON, Paul Michael | Director | Church Barn Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 71575390001 | |||||
| TREVENA, Fredrick Donald | Director | 9 Nevy Fold Avenue Horwich BL6 6QG Bolton Lancashire | British | 11079520001 | ||||||
| WADDICOR, Alec | Director | North Dean Black Beck Woods Storrs LA23 Bowness On Windermere Cumbria | British | 62591020001 |
¿Tiene ARMPLEDGE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 15 may 1986 Entregado el 16 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings in peto street, blackburn, lancashire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 dic 1984 Entregado el 29 dic 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the northerly side of mayfield street, blackburn. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ARMPLEDGE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0