CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01612613
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOLVERS LIMITED18 abr 198618 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 dic 2013

    Estado de capital el 19 dic 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2013

    11 páginasAA

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Nombramiento de Denise Williams como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Preedy como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario

    2 páginasTM02

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Richard Ian Preedy como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Ms Kerry Jane Crompton el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952100001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    MCGRATH, John
    215 Britten Road
    Brighton Hill
    RG22 4HW Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    215 Britten Road
    Brighton Hill
    RG22 4HW Basingstoke
    Hampshire
    Irish86625860001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SPICER, Barry Leslie
    3 Inwood Kilns
    The Street Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    Secretario
    3 Inwood Kilns
    The Street Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    British41726530001
    STAFFORD, Andy
    Park House
    Park Terrace
    KT4 Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    Park House
    Park Terrace
    KT4 Worcester Park
    Surrey
    British23777210001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Director
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    GOODBOURN, Caroline
    Honeysuckle Cottage
    London Road, Hill Brow
    GU33 7NS Liss
    Hampshire
    Director
    Honeysuckle Cottage
    London Road, Hill Brow
    GU33 7NS Liss
    Hampshire
    British51272690003
    GORDON, Christopher Murray
    Farthings Rake Road
    GU33 7HB Liss
    Hampshire
    Director
    Farthings Rake Road
    GU33 7HB Liss
    Hampshire
    British16761550001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Director
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    O'MALLEY, Douglas Charles
    Sunnycroft Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AR Guildford
    Surrey
    Director
    Sunnycroft Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AR Guildford
    Surrey
    British16761560001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    THOMPSON, Martin
    10 Oakley Dell
    GU4 7HJ Guildford
    Surrey
    Director
    10 Oakley Dell
    GU4 7HJ Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish51272670002
    VELUSSI, Luca
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomItalian113413330002

    ¿Tiene CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 oct 2007
    Entregado el 15 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transacciones
    • 15 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creado el 19 oct 2006
    Entregado el 02 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 mar 2002
    Entregado el 26 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ockford mill osckford road godalming surrey title number SY445686.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 mar 2002
    Entregado el 20 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 17 jul 1998
    Entregado el 06 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a ockford mill ockford road godalming surrey t/n SY393323 and SY445686. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit guarantee registered pursuant to an order or court dated 11/6/92
    Creado el 30 ago 1988
    Entregado el 24 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee agreement
    Breve descripción
    Rent deposit funds in the sum of £31,500 plus accrued interest thereon held by the mortgagees in a deposit account.
    Personas con derecho
    • Associated British Foods Pension Trustees Limited
    Transacciones
    • 24 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 17 jun 1988
    Entregado el 07 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jul 1988Registro de una carga
    • 27 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2014Inicio de la liquidación
    05 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0