DERBY JOINERY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DERBY JOINERY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01615045 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DERBY JOINERY LIMITED?
- Instalación de carpintería (43320) / Construcción
¿Dónde se encuentra DERBY JOINERY LIMITED?
Dirección de la sede social | Eaton Court Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Hertfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DERBY JOINERY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GEE JOINERY LIMITED | 01 jun 1982 | 01 jun 1982 |
HALECOLT LIMITED | 18 feb 1982 | 18 feb 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DERBY JOINERY LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DERBY JOINERY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2022 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Sir Robert Mcalpine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Paul Cole como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Lorna Jean Emmett como director el 30 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2021 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2020 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Leighton More como director el 04 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Miles Colin Shelley como director el 04 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Reginald Bolt como director el 31 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DERBY JOINERY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEARSON, Kevin John | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | 179471260001 | |||||||
EMMETT, Lorna Jean | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 263164950001 | ||||
MORE, James Leighton | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 96473500003 | ||||
COWEN, Brendon Raymond | Secretario | 92 Eastmoor Park AL5 1BP Harpenden Hertfordshire | British | 1234020001 | ||||||
REEDER, John Peter | Secretario | 15 Home Mead HA7 1AF Stanmore Middlesex | British | 9933790001 | ||||||
WALKER, Robert Peter | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
WALKER, Robert Peter | Secretario | 30 The Copse Fields End HP1 2TA Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
BARRON, Peter Edward | Director | St Brides Cottage Carrow Hill St Brides Netherwent NP6 3AU Newport Gwent | British | Chartered Civil Engineer | 605090001 | |||||
BOLT, Andrew Reginald | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | United Kingdom | British | Construction & Property | 63420900002 | ||||
BUDDEN, Derek Ernest Arthur | Director | Elmfield 25 Batchworth Lane HA6 3DU Northwood Middlesex | British | Chartered Accountant | 605520001 | |||||
COLE, John Paul | Director | 42 Dove Road DE5 3GR Ripley Derbyshire | British | Construction Engineer | 56698500001 | |||||
COOPER, John Edwin | Director | The Dial House Holcot Road Walgrave NN6 9QN Northampton | British | Engineer | 51303700001 | |||||
ELLIOTT, Trevor Arthur | Director | 14 Hallington Drive DE75 7QX Heanor Derbyshire | British | Manager | 11492420001 | |||||
KEANE, James Henry | Director | 81 Cause End Road MK43 9DE Wootton Bedfordshire | United Kingdom | British | Engineer | 75918300002 | ||||
LEGGOTT, Paul Edward | Director | Oak House Grosvenor Close SK9 1QY Wilmslow Cheshire | British | Engineer | 44269440001 | |||||
SHELLEY, Miles Colin | Director | 20 Tuffnells Way AL5 3HQ Harpenden Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 44005940002 | ||||
WALKER TAYLOR, Patrick Hugh | Director | 15 Upper Hill Rise WD3 7NU Rickmansworth Hertfordshire | British | Group Financial Director | 111015350001 | |||||
WOOLF, Robert Anthony | Director | 2 Berkeley Road Barnes SW13 9LZ London | England | British | Chartered Accountant | 5215540002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DERBY JOINERY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Robert Mcalpine Limited | 06 abr 2016 | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene DERBY JOINERY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 03/11/95 | Creado el 22 ago 2002 Entregado el 04 sept 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Any sum or sums standing to the credit of the account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental deed | Creado el 29 abr 1994 Entregado el 17 may 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada And amending a composite guarantee and debenture dated 30 april 1993 | |
Breve descripción F/H property being land and buildings on the north side of heanor road smalley. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 30 abr 1993 Entregado el 06 may 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of "the facilities" (as defined) or this charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 10 feb 1987 Entregado el 16 feb 1987 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold - land & buildings on the north west side of uttoxter old road derby title no. Dy 94255. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 10 feb 1987 Entregado el 16 feb 1987 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land & buildings on the south west side of stepping lane derby title no dy 109868. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 08 ene 1987 Entregado el 12 ene 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H smalley depot heanor road smalley derbyshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0