SIGNAL RADIO LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SIGNAL RADIO LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01633042 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIGNAL RADIO LIMITED?
- Radiodifusión (60100) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra SIGNAL RADIO LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 London Bridge Street SE1 9GF London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGNAL RADIO LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
NORTH STAFFORDSHIRE & SOUTH CHESHIRE BROADCASTING LIMITED | 04 may 1982 | 04 may 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGNAL RADIO LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 28 jun 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGNAL RADIO LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jun 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 5 páginas | AA | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2018 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 02 mar 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Anthony David Tompkins como director el 30 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Norman Mckeown como director el 30 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Charles Gill como director el 30 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony Tompkins como secretario el 30 nov 2016 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft como director el 30 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 19 dic 2016 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England a 1 London Bridge Street London SE1 9GF el 02 dic 2016 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 sept 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de John Mccann como director el 12 may 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SIGNAL RADIO LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILL, Michael Charles | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | United Kingdom | British | Accountant | 123013340001 | ||||
LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | Chief Financial Officer | 163116880001 | ||||
TAUNTON, Scott William | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 80505610007 | ||||
ALLEN, Stephen | Secretario | 1 Avenue Cottages High Street Mill Hill NW7 1QY London | British | 68299700001 | ||||||
ASHTON, Keir | Secretario | Top Flat 82 Brondesbury Road NW6 6RX London | British | 68400270001 | ||||||
DOWNEY, James Robinson | Secretario | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | Finance Director | 107097580001 | |||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Secretario | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Finance Director | 4250810002 | |||||
MACHIN, Barrington Howard | Secretario | Westfield Mill Lane Wetley Rocks ST9 0BN Stoke On Trent Staffordshire | British | 2107970001 | ||||||
SADLER, Keith John | Secretario | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
TOMPKINS, Anthony | Secretario | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165681340001 | |||||||
OLSWANG COSEC LIMITED | Secretario corporativo | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
BEAUMONT, Martin Dudley | Director | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | Businessman | 10084840001 | ||||
COATES, Peter | Director | Brook Farm Newcastle Road Betchton CW11 2TG Sandbach Cheshire | England | British | Managing Director | 25115560002 | ||||
DEMUTH, Nicholas | Director | 23 Ashburton Mansions Ashburton Road SW10 London | British | Retired | 42800430002 | |||||
DOWNEY, James Robinson | Director | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | Finance Director | 107097580001 | ||||
EVINGTON, John Charles | Director | Tollgate Cottage Elton Road Ettiley Heath CW11 9NF Sandbach Cheshire | British | Programmer Director | 76357680001 | |||||
EVINGTON, John Charles | Director | Tollgate Cottage Elton Road Ettiley Heath CW11 9NF Sandbach Cheshire | British | Programme Director | 76357680001 | |||||
GOODWIN, Jonathan Philip Pryce | Director | 29 Broadhinton Road SW4 0LT London | British | Investment Banker | 68743940001 | |||||
HOLDER, Carol Elizabeth | Director | Hawthorns Hall University Of Keele ST5 5AF Keele Staffs | British | University Lecturer | 76908040001 | |||||
HURST, Christopher David | Director | 8 Comber Way WA16 9BT Knutsford Cheshire | British | Sales Director | 46960000003 | |||||
JONES, David Gordon | Director | 28 Bracken Close Tittensor ST12 9JD Stoke On Trent Staffordshire | British | Financial Director | 990360001 | |||||
JOSEPHS, John Irving | Director | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 3830990001 | ||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Director | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Finance Director | 4250810002 | |||||
LEADBEATER, Edward Timothy David | Director | Crofts Cottage Bagot Street Abbots Bromley WS15 3DB Rugeley Staffordshire | British | Solicitor | 34775550001 | |||||
LINSCOTT, Ann | Director | 32 Bracken Close Tittensor ST12 9JD Stoke On Trent Staffs | British | Public Relations Officer | 70490330001 | |||||
LOVATT, Harry | Director | 11 Edinburgh Road Benowa Waters Queensland 4217 Australia | British | Chief Executive | 50414290002 | |||||
MACHIN, Barrington Howard | Director | Westfield Mill Lane Wetley Rocks ST9 0BN Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 2107970001 | ||||
MACKENZIE, Ashley Calder | Director | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | Director | 59529980005 | |||||
MACKENZIE, Kelvin Calder | Director | Christophers Lockstone Close KT13 8EF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Director | 141795340001 | ||||
MAY, Douglas Herbert | Director | Pilgrims Latch Eype DT6 6AL Bridport Dorset | British | Company Director | 57789540001 | |||||
MCCANN, John | Director | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | Managing Director | 75447990001 | ||||
MCKEOWN, Norman | Director | Ormeau Road BT7 1EB Belfast Havelock House Northern Ireland | Northern Ireland | British | Director | 165664890001 | ||||
OWEN, Glyn David | Director | 10 Woodside Drive CW11 0JP Sandbach Cheshire | British | Sales Director | 26534930001 | |||||
PRESTON, James Heath | Director | 6 Newenden Road WN1 2PX Wigan Lancashire | British | Retired | 28469580001 | |||||
RICHARDSON, Allan | Director | Woodcott House Farm Wrenbury Heath CW5 8EE Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | Farmer | 3030960001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIGNAL RADIO LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Wireless Group (Ilrs) Ltd | 06 abr 2016 | 401 Faraday Street, Birchwood Park WA3 6GA Warrington Ground Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene SIGNAL RADIO LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee | Creado el 21 oct 1999 Entregado el 03 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All liability crystallised and charges expenses due. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture | Creado el 21 oct 1999 Entregado el 03 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 29 sept 1999 Entregado el 20 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever save for those liabilities specifically excluded by the terms of a letter executed as a deed by the companies and the bank | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 07 oct 1997 Entregado el 09 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 27 nov 1996 Entregado el 30 nov 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 16 ago 1990 Entregado el 04 sept 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings on the north side of haig road, knutsfard, cheshire title no ch 205013 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0