SIGNAL RADIO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSIGNAL RADIO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01633042
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SIGNAL RADIO LIMITED?

    • Radiodifusión (60100) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra SIGNAL RADIO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 London Bridge Street
    SE1 9GF London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGNAL RADIO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NORTH STAFFORDSHIRE & SOUTH CHESHIRE BROADCASTING LIMITED04 may 198204 may 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGNAL RADIO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 jun 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGNAL RADIO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jun 2020

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    5 páginasAA

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 02 mar 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Anthony David Tompkins como director el 30 sept 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Norman Mckeown como director el 30 abr 2017

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Michael Charles Gill como director el 30 nov 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony Tompkins como secretario el 30 nov 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft como director el 30 nov 2016

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 19 dic 2016

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England a 1 London Bridge Street London SE1 9GF el 02 dic 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 sept 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Mccann como director el 12 may 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SIGNAL RADIO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GILL, Michael Charles
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Director
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant123013340001
    LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Director
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer163116880001
    TAUNTON, Scott William
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    Director
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCompany Director80505610007
    ALLEN, Stephen
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    Secretario
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    British68299700001
    ASHTON, Keir
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    Secretario
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    British68400270001
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Secretario
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    BritishFinance Director107097580001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    BritishFinance Director4250810002
    MACHIN, Barrington Howard
    Westfield Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    Westfield Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    British2107970001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Secretario
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    TOMPKINS, Anthony
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Secretario
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    165681340001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Secretario corporativo
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Director
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishBusinessman10084840001
    COATES, Peter
    Brook Farm Newcastle Road
    Betchton
    CW11 2TG Sandbach
    Cheshire
    Director
    Brook Farm Newcastle Road
    Betchton
    CW11 2TG Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director25115560002
    DEMUTH, Nicholas
    23 Ashburton Mansions
    Ashburton Road
    SW10 London
    Director
    23 Ashburton Mansions
    Ashburton Road
    SW10 London
    BritishRetired42800430002
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Director
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritishFinance Director107097580001
    EVINGTON, John Charles
    Tollgate Cottage
    Elton Road Ettiley Heath
    CW11 9NF Sandbach
    Cheshire
    Director
    Tollgate Cottage
    Elton Road Ettiley Heath
    CW11 9NF Sandbach
    Cheshire
    BritishProgrammer Director76357680001
    EVINGTON, John Charles
    Tollgate Cottage
    Elton Road Ettiley Heath
    CW11 9NF Sandbach
    Cheshire
    Director
    Tollgate Cottage
    Elton Road Ettiley Heath
    CW11 9NF Sandbach
    Cheshire
    BritishProgramme Director76357680001
    GOODWIN, Jonathan Philip Pryce
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    Director
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    BritishInvestment Banker68743940001
    HOLDER, Carol Elizabeth
    Hawthorns Hall
    University Of Keele
    ST5 5AF Keele
    Staffs
    Director
    Hawthorns Hall
    University Of Keele
    ST5 5AF Keele
    Staffs
    BritishUniversity Lecturer76908040001
    HURST, Christopher David
    8 Comber Way
    WA16 9BT Knutsford
    Cheshire
    Director
    8 Comber Way
    WA16 9BT Knutsford
    Cheshire
    BritishSales Director46960000003
    JONES, David Gordon
    28 Bracken Close
    Tittensor
    ST12 9JD Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    28 Bracken Close
    Tittensor
    ST12 9JD Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishFinancial Director990360001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector3830990001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Director
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    BritishFinance Director4250810002
    LEADBEATER, Edward Timothy David
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    Director
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    BritishSolicitor34775550001
    LINSCOTT, Ann
    32 Bracken Close
    Tittensor
    ST12 9JD Stoke On Trent
    Staffs
    Director
    32 Bracken Close
    Tittensor
    ST12 9JD Stoke On Trent
    Staffs
    BritishPublic Relations Officer70490330001
    LOVATT, Harry
    11 Edinburgh Road
    Benowa Waters
    Queensland 4217
    Australia
    Director
    11 Edinburgh Road
    Benowa Waters
    Queensland 4217
    Australia
    BritishChief Executive50414290002
    MACHIN, Barrington Howard
    Westfield Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    Westfield Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director2107970001
    MACKENZIE, Ashley Calder
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    Director
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector59529980005
    MACKENZIE, Kelvin Calder
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    Director
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishDirector141795340001
    MAY, Douglas Herbert
    Pilgrims Latch
    Eype
    DT6 6AL Bridport
    Dorset
    Director
    Pilgrims Latch
    Eype
    DT6 6AL Bridport
    Dorset
    BritishCompany Director57789540001
    MCCANN, John
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Director
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishManaging Director75447990001
    MCKEOWN, Norman
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    Northern Ireland
    Director
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishDirector165664890001
    OWEN, Glyn David
    10 Woodside Drive
    CW11 0JP Sandbach
    Cheshire
    Director
    10 Woodside Drive
    CW11 0JP Sandbach
    Cheshire
    BritishSales Director26534930001
    PRESTON, James Heath
    6 Newenden Road
    WN1 2PX Wigan
    Lancashire
    Director
    6 Newenden Road
    WN1 2PX Wigan
    Lancashire
    BritishRetired28469580001
    RICHARDSON, Allan
    Woodcott House Farm
    Wrenbury Heath
    CW5 8EE Nantwich
    Cheshire
    Director
    Woodcott House Farm
    Wrenbury Heath
    CW5 8EE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritishFarmer3030960001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SIGNAL RADIO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    401 Faraday Street, Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    England
    06 abr 2016
    401 Faraday Street, Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1989
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03115084
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene SIGNAL RADIO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee
    Creado el 21 oct 1999
    Entregado el 03 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All liability crystallised and charges expenses due. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale,London Branch
    Transacciones
    • 03 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 21 oct 1999
    Entregado el 03 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale,London Branch
    Transacciones
    • 03 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 sept 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever save for those liabilities specifically excluded by the terms of a letter executed as a deed by the companies and the bank
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 oct 1997
    Entregado el 09 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 27 nov 1996
    Entregado el 30 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 08 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 ago 1990
    Entregado el 04 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on the north side of haig road, knutsfard, cheshire title no ch 205013 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 sept 1990Registro de una carga
    • 09 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0