BROADREACH HOUSE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBROADREACH HOUSE
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 01634415
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BROADREACH HOUSE?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
    • Actividades de atención residencial para personas con dificultades de aprendizaje, salud mental y abuso de sustancias (87200) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra BROADREACH HOUSE?

    Dirección de la sede social
    C/O Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BROADREACH HOUSE?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 may 2019
    Próximas cuentas vencen el29 feb 2020
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2018

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BROADREACH HOUSE?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta06 nov 2019
    Próxima declaración de confirmación vence20 nov 2019
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta06 nov 2018
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROADREACH HOUSE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 ago 2024

    15 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 ago 2023

    16 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 ago 2022

    14 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 ago 2021

    14 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Informe de progreso del administrador

    19 páginasAM10

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    17 páginasAM22

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    18 páginasAM10

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA/AM02SOC

    20 páginasAM02

    Declaración de la propuesta del administrador

    41 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de 465 Tavistock Road Plymouth Devon PL6 7HE England a C/O Centenary House Peninsula Park Rydon Lane Exeter EX2 7XE el 25 jul 2019

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Cese del nombramiento de John Joseph Kiddey como director el 23 may 2019

    1 páginasTM01

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 10

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 10

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 016344150015

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 10

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 9

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 8

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 016344150013

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 11

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 016344150013

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 10

    2 páginasMR05

    ¿Quiénes son los directivos de BROADREACH HOUSE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DYER, Cynthia Wendy
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    Devon
    England
    Secretario
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    Devon
    England
    185922460001
    DORMER, Georgina
    Barton Road
    Badersfield
    NR10 5JR Norwich
    58
    England
    Director
    Barton Road
    Badersfield
    NR10 5JR Norwich
    58
    England
    United KingdomBritishChief Executive239804390002
    GAVIN, Christina Saunders
    Barton
    Harbertonford
    TQ9 7UE Totnes
    Lower Washbourne
    Devon
    England
    Director
    Barton
    Harbertonford
    TQ9 7UE Totnes
    Lower Washbourne
    Devon
    England
    United KingdomAmericanNone164385900001
    HAYES, Raymond Charles Svend O'Connell
    Buttville House
    Derby Road
    TQ7 1JL Kingsbridge
    Devon
    Director
    Buttville House
    Derby Road
    TQ7 1JL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritishSolicitor60313380001
    JONES, Timothy Michael
    Langmeads
    Belstone
    EX20 1RA Okehampton
    Devon
    Director
    Langmeads
    Belstone
    EX20 1RA Okehampton
    Devon
    EnglandBritishChartered Surveyor32775520001
    KITSON, James Buller
    Botus Fleming
    Saltash
    Churchtown
    Cornwall
    United Kingdom
    Director
    Botus Fleming
    Saltash
    Churchtown
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant160122150001
    LOFTUS, Christopher John
    Grammont Parsonage Road
    Newton Ferrers
    PL8 1AT Plymouth
    Devon
    Director
    Grammont Parsonage Road
    Newton Ferrers
    PL8 1AT Plymouth
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant16148490001
    MARSHALL, Craig Rodger
    Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    C/O Centenary House
    Director
    Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    C/O Centenary House
    EnglandBritishTraining Manager107987460001
    WALKER, Andrew Donaldson
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    Secretario
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    British22986190001
    WALLACE, Judith Thaddeus
    Langdale 19 Tavistock Road
    PL5 3DG Plymouth
    Devon
    Secretario
    Langdale 19 Tavistock Road
    PL5 3DG Plymouth
    Devon
    British9615430001
    WARD, Richard Edmund
    Fieldhead New Road
    PL14 4HB Liskeard
    Cornwall
    Secretario
    Fieldhead New Road
    PL14 4HB Liskeard
    Cornwall
    British46147030002
    ADAMS, Peter John
    Ballyholme
    Manor Bourne Down Thomas
    PL9 0AS Plymouth
    Director
    Ballyholme
    Manor Bourne Down Thomas
    PL9 0AS Plymouth
    BritishCivil Engineer10484340002
    ADEY, John Victor
    The Old Cellar
    Stoney Stratton
    BA4 6EA Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    The Old Cellar
    Stoney Stratton
    BA4 6EA Shepton Mallet
    Somerset
    BritishGroup Treasurer50847880002
    BADGE, Peter Gilmour Noto, Sir
    6 Springfield
    Bedford Road
    PL20 7QS Horrabridge
    Devon
    Director
    6 Springfield
    Bedford Road
    PL20 7QS Horrabridge
    Devon
    EnglandBritishRetired Chief Metropolitan Mag108248270001
    BERNSTEIN, David Sidney, The Hon
    27 Tregunter Road
    SW10 9LS London
    Director
    27 Tregunter Road
    SW10 9LS London
    BritishCompany Director5096490001
    FENWICK, Sebastian Edmund Stephen
    Shilstone
    Modbury
    PL21 0TW Ivybridge
    Devon
    Director
    Shilstone
    Modbury
    PL21 0TW Ivybridge
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director126801890001
    GAVIN, Christina Saunders
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    Director
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    United KingdomAmericanNone164385900001
    GEORGAKIS, Phillip
    Flat 3 Hyde Park Gardens
    W2 2NB London
    Director
    Flat 3 Hyde Park Gardens
    W2 2NB London
    BritishEconomist22986210001
    HERBERT, Edward
    1 Perches Close
    Newton Ferrers
    PL8 1HZ Plymouth
    Devon
    Director
    1 Perches Close
    Newton Ferrers
    PL8 1HZ Plymouth
    Devon
    BritishRetired22986220001
    HUGHES, Lorraine Roberta
    Vereley House
    BH24 4HH Ringwood
    Hampshire
    Director
    Vereley House
    BH24 4HH Ringwood
    Hampshire
    BritishKindergarten Owner106702040001
    KIDDEY, John Joseph
    15 Whidborne Avenue
    TQ1 2PG Torquay
    Devon
    Director
    15 Whidborne Avenue
    TQ1 2PG Torquay
    Devon
    EnglandBritishRetired99411650001
    LEICESTER-THACKARA, James Antony
    157-159 Fore Street
    PL12 6AB Saltash
    Cornwall
    Director
    157-159 Fore Street
    PL12 6AB Saltash
    Cornwall
    BritishChartered Accountant4927450001
    LEICESTER-THACKARA, Vanessa J
    Rivermead House
    Two Waters Foot
    PL14 6HT Liskeard
    Cornwall
    Director
    Rivermead House
    Two Waters Foot
    PL14 6HT Liskeard
    Cornwall
    BritishCompany Director12875110002
    LOPES, Henry Massey, The Hon
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    Director
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    BritishChartered Surveyor24683680001
    LOPES, Jean Campbell Sorell, The Hon
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    Director
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    EnglandAustralianNone106953490001
    MASSEY, Charlotte, Dr
    c/o Mrs Cynthia Dyer
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    England
    Director
    c/o Mrs Cynthia Dyer
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    England
    EnglandBritishRetired Gp223578560001
    MORGAN, Heather Margaret
    40 Countess Wear Road
    EX2 6LR Exeter
    Devon
    Director
    40 Countess Wear Road
    EX2 6LR Exeter
    Devon
    EnglandEnglishSolicitor79971780001
    PROSSER, Sarah Louise
    165 Alma Road
    Milehouse
    PL3 4HQ Plymouth
    Devon
    Director
    165 Alma Road
    Milehouse
    PL3 4HQ Plymouth
    Devon
    BritishSales Director58450550003
    ROWELL, Oliver John
    Little Calumet Sandy Lane
    Ivy Hatch
    TN15 0PD Sevenoaks
    Kent
    Director
    Little Calumet Sandy Lane
    Ivy Hatch
    TN15 0PD Sevenoaks
    Kent
    BritishRetired General Manager12287310001
    SCHIFFMANN, Sybille Erika
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    Director
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    EnglandIrishLeadership Consultant127456240001
    SEWELL, Michael Arthur
    Hartley Villa 157 Mannamead Road
    PL3 5NU Plymouth
    Devon
    Director
    Hartley Villa 157 Mannamead Road
    PL3 5NU Plymouth
    Devon
    BritishRetired6636210001
    URWIN, Peter John Michael
    Myrtle Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NQ Saltash
    Cornwall
    Director
    Myrtle Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NQ Saltash
    Cornwall
    EnglandBritishMedical Practitioner125967650001
    WAKEFIELD, David Anthony
    53 Ringford Road
    SW18 1RP London
    Director
    53 Ringford Road
    SW18 1RP London
    United KingdomBritishNon Executive Director8047330001
    WALKER, Andrew Donaldson
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    Director
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    BritishSolicitor22986190001
    WILKINSON, Peter
    Public Health Laboratory Service
    Derriford Hospital
    PL6 8DH Plymouth
    Devon
    Director
    Public Health Laboratory Service
    Derriford Hospital
    PL6 8DH Plymouth
    Devon
    BritishMedical Microbiologist22986250001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BROADREACH HOUSE?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 nov 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene BROADREACH HOUSE alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 03 ene 2019
    Entregado el 16 ene 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    All of the freehold property known as long reach house registered as vescourt cottage, hartley road, plymouth PL3 5LW registered under title number DN363827.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Belstone Fox Limited
    Transacciones
    • 16 ene 2019Registro de una carga (MR01)
    • 27 jun 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2018
    Entregado el 17 dic 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    All that freehold land and buildings known as 465 tavistock road, plymouth as registered with title absolute at the land registry under title number DN62025.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Futurebuilders England Limited
    Transacciones
    • 17 dic 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 08 dic 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    The old grammar school longcause plympton t/n DN579260.
    Personas con derecho
    • The Trustees for the Time Being of Heles Exhibition Foundation at Plympton
    Transacciones
    • 08 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 27 jun 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Mortgage
    Creado el 21 oct 2010
    Entregado el 23 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a closereach longcause plympton st maurice plymouth devon t/no. DN59004 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 12 sept 2007
    Entregado el 20 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 2 ocean quay richmonds walk plymouth t/no DN213497 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Mortgage
    Creado el 12 sept 2007
    Entregado el 20 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 1 ocean way richmond walk plymouth devon t/no DN213498 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Charge over property
    Creado el 12 sept 2007
    Entregado el 14 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the west side or richmond walk stonehouse plymouth t/n DN213498 together with all rights.
    Personas con derecho
    • Futurebuilders England Limited
    Transacciones
    • 14 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Legal charge
    Creado el 16 abr 2007
    Entregado el 17 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 2 ocean quay richmond walk plymouth.
    Personas con derecho
    • Futurebuilders England Limited
    Transacciones
    • 17 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Legal mortgage
    Creado el 15 dic 1989
    Entregado el 21 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H old grammar school house, george lane, plympton, st maurice plympton, plymouth, t/n dn 59004 goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1989Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 29 nov 1989
    Entregado el 30 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a or being 465 tavistock road, plymouth t/n dn 62025 and all buildings & fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 1989Registro de una carga
    • 20 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 15 ago 1988
    Entregado el 22 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Wilmore 465 tavistock road, plymouth devon t/n dn 62025 and the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ago 1988Registro de una carga
    • 08 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 28 jul 1988
    Entregado el 05 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Old grammar school house george land plympton st maurice plymouth devon t/n dn 59004 and/or the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1988Registro de una carga
    • 20 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed
    Creado el 31 dic 1982
    Entregado el 13 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 25/5/82 and a charge dated 25/5/82
    Breve descripción
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and working capital f/h wilmore, 465 tavistock road, plymouth devon title no: dn 62025.
    Personas con derecho
    • Bupa Investments LTD
    Transacciones
    • 13 ene 1983Registro de una carga
    • 08 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 28 may 1982
    Entregado el 09 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Wilmore, 465 tavistock road, plymouth, title no. Dn 62025.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1982Registro de una carga
    • 08 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 28 may 1982
    Entregado el 09 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 25/5/82
    Breve descripción
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital wilmore, 465 tavistock road, roborough, plymouth title no dn 62025.
    Personas con derecho
    • Bupa Investments Limited
    Transacciones
    • 09 jun 1982Registro de una carga
    • 14 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BROADREACH HOUSE algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 jul 2019Inicio de la administración
    14 ago 2020Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Lucinda Clare Coleman
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Profesional
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Stephen James Hobson
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Profesional
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    2
    FechaTipo
    14 ago 2020Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Lucinda Clare Coleman
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Profesional
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Stephen James Hobson
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Profesional
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0