PAYCHANNEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPAYCHANNEL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01645175
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PAYCHANNEL LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra PAYCHANNEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAYCHANNEL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRANSACSYS APPLICATIONS LTD23 may 200323 may 2003
    G2 LIMITED.20 sept 200220 sept 2002
    TRANSACSYS APPLICATIONS LIMITED 09 abr 200109 abr 2001
    GIROVEND SYSTEMS LIMITED21 oct 199721 oct 1997
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED23 ago 198223 ago 1982
    COLAW ONE LIMITED21 jun 198221 jun 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PAYCHANNEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAYCHANNEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 mar 2010

    Estado de capital el 18 mar 2010

    • Capital: GBP 103
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    12 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    14 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    14 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2005

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas225

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed transacsys applications LTD\certificate issued on 31/07/06
    2 páginasCERTNM

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de PAYCHANNEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Secretario
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    CLARKSON, James Robert
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    Director
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    United KingdomBritish72610550001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    Director
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Secretario
    75 Park Road
    W4 3EY London
    British37599910001
    BAILEY, John
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    Secretario
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    British41823950002
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    Secretario
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Secretario
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secretario
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Secretario
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    Secretario
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    British43153490002
    CLAIR, Peter
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    Director
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    British47537030003
    CLARK, Ronald Thomson
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    Director
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    British69705410001
    DRUDY, Carmel Ann
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    Director
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    British40928410001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Director
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Director
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    GREHS, Barbara
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    Director
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    British42212470001
    HARRIS, Glyn
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    Director
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    British8555610001
    KOBEISSI, Mario
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    Director
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    British92156280001
    LAING, Andrew Murray
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    Director
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    British28771390001
    LAVERACK, Harold Thomas
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    Director
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    British19389720001
    MADISON HAYNE, Hayne
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    Director
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    American45373130001
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    Director
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Director
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Director
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Director
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    EnglandBritish78149370002
    SCHOFIELD, Janet Elizabeth
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    Director
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    British36356290002
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    Director
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Director
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    Director
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WILLIAMS, Richard Idwal
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    Director
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    British40830150002

    ¿Tiene PAYCHANNEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage of life policy
    Creado el 25 feb 1997
    Entregado el 11 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or the principal debtor (as defined) to the chargee under the terms of the deed
    Breve descripción
    The company with full title guarantee assigned and agreed to assign to the bank:(a) the policy of assurance set out in part iv of this schedule and all moneys (including bonuses) that may become payable thereunder.(b) all sums payable to the company in connection with the policies pursuant to section 76 of the insurance companies act 1982. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 feb 1997
    Entregado el 11 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All f/h & l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough.t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 sept 1996
    Entregado el 19 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 30 nov 1990
    Entregado el 20 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1990Registro de una carga
    • 26 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Counter-indemnity & charge
    Creado el 13 may 1988
    Entregado el 26 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details see form 395 ref: M49). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Graig Shipping PLC
    Transacciones
    • 26 may 1988Registro de una carga
    • 26 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0