HIC TREASURY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HIC TREASURY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01647393 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HIC TREASURY LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HIC TREASURY LIMITED?
Dirección de la sede social | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HIC TREASURY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WEMBLEY INTERNATIONAL HOTEL LIMITED | 06 abr 1983 | 06 abr 1983 |
PARISGLEN LIMITED | 29 jun 1982 | 29 jun 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HIC TREASURY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HIC TREASURY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 15 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HIC TREASURY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kimberly Jane Coari como director el 04 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 23 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Kimberly Jane Coari el 01 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr George Christopher Ogle el 28 ene 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Geoffrey Beeston el 24 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr James Owen Percival el 01 jul 2011 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Hilton Corporate Director Llc el 19 jun 2017 | 1 páginas | CH02 | ||
Nombramiento de Kimberly Jane Coari como director el 19 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Michelle Momdjian como director el 19 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Philip Heath como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr George Christopher Ogle como director el 19 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HIC TREASURY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 125128960001 | |||||||
BEASLEY, Stuart | Director | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | Financial Controller | 188237620002 | ||||
BEESTON, Richard Geoffrey | Director | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 242993840002 | ||||
MOMDJIAN, Michelle | Director | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | Attorney | 253271050001 | ||||
OGLE, George Christopher | Director | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | Attorney | 253271070002 | ||||
PERCIVAL, James Owen | Director | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | Accountant | 161274380001 | ||||
HILTON CORPORATE DIRECTOR LLC | Director corporativo | 251 Little Falls Drive 19808 Wilmington Corporation Service Company Delaware United States | 134775210001 | |||||||
HUGHES, Barbara | Secretario | Flat 3 11 Hazelmere Road NW6 6PY London | British | 45702460001 | ||||||
SINGLETON, Jane | Secretario | 76 Wilton Road Muswell Hill N10 1LT London | British | 49785210001 | ||||||
WILSON, Brian | Secretario | Tudor Cottage 70 High Street, Eaton Bray LU6 2DP Dunstable | British | 125151140001 | ||||||
LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 60530770001 | |||||||
ANDREW, David | Director | White Acre 15 Dales Way Guiseley LS20 8JN Leeds | British | Marketing Director | 41761510001 | |||||
ATKIN, Peter Neil | Director | Hurst Dene New Place RH20 1AT Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 10294000001 | ||||
BAMSEY, John Anthony | Director | Cranley Road Burwood Park KT12 5BL Hersham Treetops 26 Surrey | England | British | Company Director | 130102260001 | ||||
BOULD, Christopher John | Director | The West Wing Pensax Court Pensax WR6 6XJ Worcester Worcestershire | British | Sales Director | 110275470001 | |||||
BOWCOCK, Philip Hedley | Director | East Barn Glory Hill Farm HP9 1XE Beaconsfield Bucks | British | Company Director | 111188430001 | |||||
CARTER, Ian Russell | Director | Lenox House South Road KT13 0NB Weybridge Surrey | British | Company Director | 102979880003 | |||||
COARI, Kimberly Jane | Director | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Vp Asset Management Europe | 265529150002 | ||||
DOBBS, John Anthony | Director | 11a North Park Avenue LS8 1DN Leeds West Yorkshire | British | Operations Director | 120544260001 | |||||
DYSON, Ian | Director | The Laurels Miles Lane KT11 2ED Cobham Surrey | British | Accountant | 50916710001 | |||||
ELKIES, Alexander George | Director | 29 Tyrell Gardens SL4 4DH Windsor Berkshire | British | Chartered Accountant | 41150300001 | |||||
FARROW, James Roger Charles | Director | 7 Downham Place South Shore FY4 1PW Blackpool Lancashire | British | Sales & Marketing Director | 9585240001 | |||||
GLICK, Steven Marc | Director | 15 Eton Villas NW3 4SG London | British | Lawyer | 28899890002 | |||||
HEATH, Christopher Philip | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park United Kingdom | England | British | Attorney | 205835660001 | ||||
HIRST, Michael Barry | Director | 16 Prowse Avenue Bushey WD2 1JR Watford Hertfordshire | England | British | Company Director | 40994810001 | ||||
HUGHES, Andrew Lawrence | Director | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | England | British | Vice President Finance | 109749210001 | ||||
HUGHES-RIXHAM, Ian | Director | 1 Grange Road HP23 5JP Tring Hertfordshire | British | Operations Director | 143730250001 | |||||
HUMPHREYS, Stephen | Director | 1 Victoria Yard Fairclough Street E1 1PP London | British | Director | 71438830002 | |||||
JAMES, Paul Frederick | Director | 53 Lonsdale Drive Oakwood EN2 7LR Enfield | British | Solicitor | 48791500001 | |||||
JONES, Annie Marie | Director | 2 Lodge Close SL7 1RB Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Human Resources Director | 162019090001 | ||||
LICHMAN, Laurence | Director | 209 Merry Hill Road WD23 1AP Bushey Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 143730380001 | |||||
MAIDEN, George Barry | Director | Fourwinds Long Walk HP8 4AW Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 8832120001 | |||||
METCALFE, Michael Stuart | Director | 16 Home Close Houghton Conquest MK45 3NH Bedford Bedfordshire | British | Operations Director | 40294180001 | |||||
NOBLE, Michael Jeremy | Director | Goathill Farm Well Hill Lane Well Hill BR6 7QJ Chelsfield Kent | England | British | Chartered Secretary | 32786810004 | ||||
POTTER, Anthony Grahame | Director | Villa Sogno Fulmer Road SL9 7EG Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 62316310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HIC TREASURY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Finance (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court, Central Park Hertfordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0