COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED

COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOMFORT LODGE (U.K.) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01653513
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOYHATCH LIMITED23 jul 198223 jul 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 jun 2018

    9 páginasLIQ03

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:re res assets in specie
    1 páginasLIQ MISC RES

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Maple Court Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 páginasAD03

    Domicilio social registrado cambiado de Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford Herts WD24 4QQ a 1 More London Place London SE1 2AF el 18 jul 2017

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Maple Court Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 páginasAD02

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:resolution in respect of remuneration etc
    1 páginasLIQ MISC RES

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 jun 2017

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Cese del nombramiento de Christopher Philip Heath como director el 07 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Oded Lifschitz como director el 07 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Robert Vincent como director el 07 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Brian Wilson como director el 09 jun 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Brian Wilson el 26 abr 2017

    2 páginasCH01

    Segunda presentación para el nombramiento de Christopher Heath como director

    6 páginasRP04AP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    18 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stuart Beasley el 12 ago 2016

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Christopher Heath como director el 15 jul 2016

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 ene 2017Clarification A second filed AP01 was registered on 24/01/2017.

    Déclaration annuelle établie au 03 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2016

    Estado de capital el 17 jun 2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Simon Robert Vincent el 21 ago 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 jun 2015

    Estado de capital el 09 jun 2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller188237620002
    PERCIVAL, James Owen
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    Director
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant161274380001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Secretario
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secretario
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    ANDREW, David
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director41761510002
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Director
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director130102260001
    BOULD, Christopher John
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    Director
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    BritishSales Director110275470001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director90379240002
    DOBBS, John Anthony
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    BritishOperations Director120544260001
    FARROW, James Roger Charles
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    Director
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    BritishSales And Marketing Director9585240001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Director
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    UsaCompany Director106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Director
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglishCompany Director142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Director
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    BritishHotelier64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Director
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director88628480001
    HEATH, Christopher Philip
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    EnglandBritishAttorney205835660001
    HIRST, Michael Barry
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    Director
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director40994810001
    HUGHES, Andrew Lawrence
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishVice President Finance109749210001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Director
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    BritishOperations Director143730250001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Director
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    BritishOperations Director143730250001
    JAMES, Paul Frederick
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    BritishSolicitor48791500001
    JONES, Annie Marie
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishHuman Resources Director162019090001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Director
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Director
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / IsraeliBusiness Executive172992020002
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director143730330001
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant8832120001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishOperations Director40294180002
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Director
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    AustriaCompany Director87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishVp Operations Central & North102495550001
    POTTER, Anthony Grahame
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director62316310001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant125139540001
    ROGERS, John
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishNone162807030001
    SHILL, Rosemarie
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Director
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director89948030001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    06 abr 2016
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01350772
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 24 mar 1986
    Entregado el 26 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 500,000
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Town & County Factors Limited
    Transacciones
    • 26 mar 1986Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 mar 1986
    Entregado el 26 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 1,500,000
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC
    Transacciones
    • 26 mar 1986Registro de una carga
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Creado el 14 feb 1985
    Entregado el 14 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84 entitled "second debenture 'a'"
    Breve descripción
    Lease by livingston development corporation in favour of the co. Recorded in the division of the general register of sasines for the county for midlothian on 10/9/84.
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 14 feb 1985Registro de una carga
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Creado el 14 feb 1985
    Entregado el 14 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two seperate debentures issued by the co to the creditor dated 26/6/84. entitled "first debenture 'a'" and "first debenture 'b"
    Breve descripción
    Lease by livingston development corporation in favour of the co. Recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 10/9/84.
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 14 feb 1985Registro de una carga
    Second equitable charge
    Creado el 02 feb 1985
    Entregado el 02 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26 june 84 or under the terms of this charge.
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land k/a site 5 phoenix way swansea enterprise park llansamlet, swansea. (See doc for further details).
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 02 feb 1985Registro de una carga
    Equitable charge
    Creado el 02 feb 1985
    Entregado el 02 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two debentures dated 26 june 84 or under the terms of this charge.
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land k/a site 5 phoenix way swansea enterprise park llansamlet, swansea. (See doc for further details).
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 02 feb 1985Registro de una carga
    Second equitable charge
    Creado el 02 feb 1985
    Entregado el 02 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26 april 1984 or under the terms of this charge.
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land comprising 5.6 acres situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke, hampshire. (See doc for further details).
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 02 feb 1985Registro de una carga
    Equitable charge
    Creado el 02 feb 1985
    Entregado el 02 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the two debentures dated 26 june 84 or under the terms of this charge
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land which comprises 5.6 acres situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke hampshire (see doc for details).
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1985Registro de una carga
    Second equitable charge
    Creado el 18 ene 1985
    Entregado el 01 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land which comprises 5.6 acres or thereabouts situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke, hampshire (see doc M23 for details).
    Personas con derecho
    • Comfort Lodge Limited
    Transacciones
    • 01 feb 1985Registro de una carga
    • 19 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second equitable charge.
    Creado el 18 ene 1985
    Entregado el 01 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land known as site 5 phoenix way, swansea enterprise park llansamlet swansea. (See doc M22 for details).
    Personas con derecho
    • Comfort Lodge Limited
    Transacciones
    • 01 feb 1985Registro de una carga
    • 19 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Creado el 17 ene 1985
    Entregado el 14 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84 entitled "second debenture 'b'"
    Breve descripción
    Lease by livingstone development corporation in favour of the company recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 10/9/84.
    Personas con derecho
    • Comfort Lodge LTD.
    Transacciones
    • 14 feb 1985Registro de una carga
    • 19 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 jun 1984
    Entregado el 12 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 2000,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1984
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • W. Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 12 jul 1984Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 26 jun 1984
    Entregado el 12 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 950,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28TH june 1984
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • W. Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 12 jul 1984Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 26 jun 1984
    Entregado el 12 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 950,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1983
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Comfort Lodge Limited
    Transacciones
    • 12 jul 1984Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 jun 1984
    Entregado el 12 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 6,000,000 supplemental to a joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1983.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transacciones
    • 12 jul 1984Registro de una carga

    ¿Tiene COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 jun 2017Inicio de la liquidación
    10 nov 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0