PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01666012 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Great Cumberland Place Marble Arch W1H 7LW London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SOLITAIRE SECRETARIES LTD | 02 sept 1999 | 02 sept 1999 |
| PARTRIDGE GREEN MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 04 nov 1983 | 04 nov 1983 |
| DARACO LIMITED | 21 sept 1982 | 21 sept 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | 4.71 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Catriona Ann Wadlow como director el 31 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pembertons Directors Limited como secretario el 05 jun 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR United Kingdom el 20 feb 2012 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Pemberton Secretaries Limited Marlborough House Wigmore Place Wigmore Lane Luton LU2 9EX United Kingdom el 13 dic 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Philip Cummings como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Catriona Ann Wadlow como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Edwards como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Edwards como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Pembertons Directors Limited como secretario | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR el 20 jun 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Bannister como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Mcgill como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Gaston como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Procter como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed solitaire secretaries LTD\certificate issued on 19/05/10 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINGS, Philip James | Director | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | England | British | 169752370001 | |||||||||
| BICKNELL, Margaret | Secretario | The Grange Church Road IP21 4EP Thelveton Norfolk | Dutch | 104528550003 | ||||||||||
| CHRISTENSEN, David John | Secretario | Clinton House High Street B46 3BP Coleshill Birmingham | British | 2641650001 | ||||||||||
| COBBINA, Sam | Secretario | 7 Hatherley Chase LU2 7FD Luton Bedfordshire | British | 109290970002 | ||||||||||
| DAVIE, Jennifer | Secretario | 17 Alston Road EN5 4EU Barnet Hertfordshire | British | 20453260002 | ||||||||||
| EDWARDS, David Charles | Secretario | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | British | 123440090026 | ||||||||||
| GREENO, Brian George | Secretario | St Mary Graces Court Cartwright Street E1 8NB London 3 | Other | 129642360001 | ||||||||||
| MCCORMACK, Margaret Mary | Secretario | 212 Mays Lane EN5 2QQ Barnet Hertfordshire | British | 53255960002 | ||||||||||
| O'BRIEN, Bridget Geraldine | Secretario | 18 Jarvis Close EN5 2RH Barnet Herts | Irish | 92828050002 | ||||||||||
| PATANI, Daksha | Secretario | 32 The Linkway EN5 2BX Barnet Hertfordshire | British | 66819710001 | ||||||||||
| TAIWO, Bolaji | Secretario | 79 New Cavendish Street W1W 6XB London | Nigerian | 121659330001 | ||||||||||
| THOMAS, Lesley Amanda | Secretario | 27 South Cottage Gardens Chorleywood WD3 5EH Rickmansworth Hertfordshire | British | 45975530002 | ||||||||||
| UTHAYANAN, Sunthar | Secretario | 7 Whistler Gardens HA8 5TU Edgware Middlesex | British | 69468150001 | ||||||||||
| WINTON, Janet | Secretario | 22 Swan Drive NW9 5DE London | Irish | 68053050001 | ||||||||||
| WOLFSON, Alan | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | 55840480004 | ||||||||||
| PEMBERTONS DIRECTORS LIMITED | Secretario corporativo | Queensway BH25 5NR New Milton 11 Hampshire United Kingdom |
| 161414040001 | ||||||||||
| BANNISTER, Nigel Gordon | Director | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 117929650001 | |||||||||
| BURTON, Christopher John | Director | 9 Gables Avenue WD6 4SP Borehamwood Hertfordshire | British | 2382240001 | ||||||||||
| EDWARDS, David Charles | Director | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 123440090026 | |||||||||
| GASTON, Michael John | Director | 302 Regents Park Road Finchley N3 2JX London Molteno House United Kingdom | England | British | 94566140001 | |||||||||
| GASTON, Michael John | Director | 1 Dents Road SW11 6JA London | England | British | 94566140001 | |||||||||
| MCGILL, Christopher Charles | Director | The Holloway HP27 0LR Whiteleaf The Old Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 140593930001 | |||||||||
| O'BRIEN, Bridget Geraldine | Director | 18 Jarvis Close EN5 2RH Barnet Herts | Irish | 92828050002 | ||||||||||
| PROCTER, William Kenneth, Mr. | Director | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 98678880005 | |||||||||
| PROCTER, William Kenneth | Director | 14 Church Crescent N3 1BG London | England | British | 98678880007 | |||||||||
| RAPLEY, Ian | Director | 28a Ickwell Road SG18 9AB Northill Bedfordshire | United Kingdom | British | 104372330001 | |||||||||
| RAYDEN, Paul | Director | 6 Elm Tree Road NW8 9JX London | England | British | 2148080003 | |||||||||
| RUSSELL, Jacqueline Anne | Director | 1 Archway Street Barnes SW13 0AS London | England | British | 288404130001 | |||||||||
| SHAPIRO, Graham Ashley | Director | Little Manor Hartsbourne Road WD2 1JJ Bushey Heath Hertfordshire | British | 4296340001 | ||||||||||
| SHULMAN, Harvey Barry | Director | 88 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | 1239130001 | |||||||||
| TAIWO, Bolaji | Director | 79 New Cavendish Street W1W 6XB London | Nigerian | 121659330001 | ||||||||||
| TAYLOR, Alastair Desmond Barham | Director | 5 Worple Avenue Wimbledon SW19 4JQ London England | England | British | 63744480001 | |||||||||
| TCHENGUIZ, Vincent Aziz | Director | Park Lane W1K 1RB London 35 | United Kingdom | British | 71890500003 | |||||||||
| THOMAS, Lesley Amanda | Director | 27 South Cottage Gardens Chorleywood WD3 5EH Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 45975530002 | |||||||||
| TONKIN, Charles Barrie | Director | 1 Stonecroft Close Barnet Road EN5 3HE Arkley, Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 48915540001 |
¿Tiene PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 08 nov 2006 Entregado el 22 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0