DONCASTERS 1516 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DONCASTERS 1516 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01669815 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DONCASTERS 1516 LIMITED?
- mecanizado (25620) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| F. V. C. LIMITED | 13 nov 1998 | 13 nov 1998 |
| FIRTH VICKERS FOUNDRY LIMITED | 29 abr 1983 | 29 abr 1983 |
| B & N (NO.63) LIMITED | 06 oct 1982 | 06 oct 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 ene 2025 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 13 mar 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 05 feb 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Egan como director el 04 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Modification des détails de Deritend International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 mar 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Deritend International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 mar 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 12 páginas | MA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA England a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 19 mar 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Barrett-Hague como secretario el 08 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Barrett-Hague como director el 08 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Repton House Bretby Business Park, Ashby Road Burton upon Trent Staffordshire DE15 0YZ England a Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA el 20 sept 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 1 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGAN, David John | Director | LS1 5AB Leeds 1 Park Row England | United Kingdom | British | 324778100001 | |||||
| QUINN, Michael Joseph | Director | LS1 5AB Leeds 1 Park Row England | Ireland | Irish | 268174890001 | |||||
| BARRETT-HAGUE, Helen | Secretario | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | 287748860001 | |||||||
| BROWN, Christopher John | Secretario | 328 Newman Road S9 1LX Sheffield South Yorkshire | British | 107518990001 | ||||||
| JACKSON, Howard Watson | Secretario | Red House Farm CV35 0EB Little Kineton Warwickshire | British | 34443700002 | ||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Secretario | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | British | 141893610001 | ||||||
| MOLYNEUX, Ian | Secretario | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | British | 164532170001 | ||||||
| TILLEY, Michael John | Secretario | Silver Birches 189 Main Street LE67 1AH Thornton Leicestershire | British | 60728390001 | ||||||
| ARMITAGE, Raymond | Director | 14 Sparken Close S80 1BN Worksop Nottinghamshire | British | 3329300001 | ||||||
| ASTON, David John Spicer | Director | The Penthouse 20 Longdon Croft Copt Heath B93 9LJ Knowle Warwickshire | British | 43094760001 | ||||||
| ASTON, Stephen Mark | Director | The Gables Rowley Avenue ST17 9AA Stafford | United Kingdom | British | 287327450002 | |||||
| BARRETT-HAGUE, Helen | Director | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | England | British | 287804380001 | |||||
| BEIGHTON, David Patrick | Director | 11 Base Green Close S12 3FB Sheffield South Yorkshire | British | 48468360001 | ||||||
| BISSELL, David Michael | Director | 10 Canford Crescent Codsall WV8 2AF Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 1057860001 | |||||
| BULL, George | Director | 3 Murdoch Close Ferndale Manor NG22 8FE Farnsfield Nottinghamshire | British | 47402550004 | ||||||
| CLELAND, Robert John | Director | The Old Vicarage Pershore Road, Upton Snodsbury WR7 4NR Worcester Worcestershire | British | 66601290001 | ||||||
| DAVIS, Richard | Director | Holmley Bank Cottage Institute Terrace Billy Row DL15 9TB Crook County Durham | British | 63658740001 | ||||||
| ELLIS, William Michael | Director | Manor Drive Worthington LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch The Manor House Leicestershire | United Kingdom | American | 134919220003 | |||||
| HARPER, Stanley Brian | Director | 2 Jerome Way Burntwood WS7 9HS Walsall West Midlands | British | 3329270001 | ||||||
| HINKS, Duncan Andrew | Director | Millennium Court First Avenue DE14 2WH Burton-On-Trent Doncasters Group Limited Staffordshire United Kingdom | England | British | 164530200005 | |||||
| HIPKINS, Graham | Director | Waresley Manor Cottage Manor Lane Waresley DY11 7XN Kidderminster Worcestershire | British | 61636950001 | ||||||
| JACKSON, Howard Watson | Director | Red House Farm CV35 0EB Little Kineton Warwickshire | United Kingdom | British | 34443700002 | |||||
| KAYSER, Michael Arthur | Director | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||
| LEWIS, Eric James | Director | Rowan House 32 Nursery Lane, Hopwas B78 3AS Tamworth Staffordshire | England | British | 75455450001 | |||||
| MARTLE, Simon David | Director | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | England | British | 151541840002 | |||||
| MATHIESON, Kenneth | Director | 17 Sandwith Road Todwick S31 0JP Sheffield South Yorkshire | British | 55633200002 | ||||||
| MCCARTAN, John | Director | 13 St Albans Road S10 4DN Sheffield South Yorkshire | British | 43354410001 | ||||||
| MOLYNEUX, Ian | Director | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | United Kingdom | British | 75284220004 | |||||
| MORGAN, Lyndon Alun | Director | 19 Holly Grove Intake S12 2DA Sheffield South Yorkshire | England | British | 48468300001 | |||||
| OXNARD, Lisa Marie | Director | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | England | British | 253562580001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Director | Millennium Court First Avenue DE14 2WH Burton-On-Trent Doncasters Group Limited Staffordshire | England | British | 42065200003 | |||||
| TILLEY, Michael John | Director | Silver Birches 189 Main Street LE67 1AH Thornton Leicestershire | British | 60728390001 | ||||||
| WATERS, Henry Maxwell | Director | Trecot King Sterndale SK17 9SF Buxton Derbyshire | British | 3329290001 | ||||||
| WATKINS, Richard Henry | Director | 2 Forge Valley Way WV5 8JP Wombourne West Midlands | England | British | 103768870001 | |||||
| WILKINS, Ian | Director | 13 West Bank Drive South Anston S31 7HT Sheffield South Yorkshire | British | 48468390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deritend International Limited | 06 abr 2016 | LS1 5AB Leeds 1 Park Row West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para DONCASTERS 1516 LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 30 ene 2017 | 28 feb 2017 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0