WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED

WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01676234
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHAMROCK AND RAMBLER COACHES LIMITED22 dic 198222 dic 1982
    HEERSCOURT LIMITED08 nov 198208 nov 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP el 14 sept 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2012

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 28 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 26 may 2012

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 20 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 feb 2012

    Estado de capital el 21 feb 2012

    • Capital: GBP 1,423,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Kenneth Mcintyre Carlaw como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Turner como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 20 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Anthony Bowler el 22 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 22 feb 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr David Paul Turner el 22 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    6 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    6 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Director
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Secretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Secretario
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    British67622780002
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director35116070001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Director
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director77984700001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Director
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    BritishCommercial Executive65346840001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Director
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Director
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    BritishGroup Operations Director2719600006

    ¿Tiene WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creado el 15 ago 1994
    Entregado el 31 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descripción
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 04 may 1994
    Entregado el 17 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston("the Agent")
    Transacciones
    • 17 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 dic 1992
    Entregado el 16 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 10 dic 1992
    Entregado el 14 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston
    Transacciones
    • 14 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 may 1989
    Entregado el 23 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Please see form 395-M528C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston
    Transacciones
    • 23 may 1989Registro de una carga
    • 17 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 27 ene 1988
    Entregado el 08 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertakng and all property and rights and assets present and future including goodwill uncalled capital. & its intellectual property all debts & other sums of money (including cash at bank) & less benefit of all securies & all vehicles. (Please see form M395 and schedule attached thereto for full details ref - M372/9FEB(ct).
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston.
    Transacciones
    • 08 feb 1988Registro de una carga
    • 17 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WEST RIDING AUTOMOBILE COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 abr 2013Fecha de disolución
    04 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0