GENERAL CABLE SERVICES LIMITED

GENERAL CABLE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGENERAL CABLE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01678830
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    • fabricación de otros cables y alambres electrónicos y eléctricos (27320) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o DELOITTE LLP
    PO BOX 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CAROL CABLE LIMITED23 feb 199023 feb 1990
    FINELINE MANUFACTURING LIMITED17 nov 198217 nov 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 3 More London Riverside London SE1 2AQ a C/O Deloitte Llp PO Box 500 2 Hardman Street Manchester M60 2AT el 07 sept 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 jul 2016

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 mar 2016

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 23/03/2016
    RES13

    Cese del nombramiento de Andrew Edward Cox como secretario el 30 dic 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Scott Garden como secretario el 30 dic 2015

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 dic 2015

    Estado de capital el 30 dic 2015

    • Capital: GBP 110,990
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Andrew Cox Consulting 3 Cross Green Formby Liverpool L37 4BH United Kingdom a 3 More London Riverside London SE1 2AQ

    1 páginasAD02

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2015

    Estado de capital el 06 ene 2015

    • Capital: GBP 110,990
    SH01

    Nombramiento de Mr Emerson Christopher Moser como director el 01 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Joseph Siverd como director el 01 jul 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ene 2014

    Estado de capital el 07 ene 2014

    • Capital: GBP 110,990
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GENERAL CABLE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GARDEN, Scott
    Exploration Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8GX Aberdeen
    Unit 8, The Enterprise Centre
    Scotland
    Secretario
    Exploration Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8GX Aberdeen
    Unit 8, The Enterprise Centre
    Scotland
    203827340001
    MOSER, Emerson Christopher
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    4
    Ky 41076-9753
    Usa
    Director
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    4
    Ky 41076-9753
    Usa
    United StatesAmerican189620520001
    ROBINSON, Brian Jerome
    c/o General Cable Corporation
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    Kentucky
    4
    Ky 41076-9753
    U S A
    Director
    c/o General Cable Corporation
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    Kentucky
    4
    Ky 41076-9753
    U S A
    UsaAmerican119666800001
    CARR, George
    1 East 4th Street
    FOREIGN Cincinnati
    Ohio Oh45202
    Usa
    Secretario
    1 East 4th Street
    FOREIGN Cincinnati
    Ohio Oh45202
    Usa
    British24247210001
    COX, Andrew Edward
    c/o Andrew Cox Consulting
    Cross Green
    Formby
    L37 4BH Liverpool
    3
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Andrew Cox Consulting
    Cross Green
    Formby
    L37 4BH Liverpool
    3
    United Kingdom
    British31638930002
    HADLEY, David Michael
    7 Woodside Way
    PE27 3JQ St Ives
    Huntingdon
    Secretario
    7 Woodside Way
    PE27 3JQ St Ives
    Huntingdon
    British177610490001
    PEARCE, Simon Marshall
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    Secretario
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    British38325900002
    SIVERD, Robert Joseph
    8051 Brill Road
    Cincinnati Oh 45243
    Ohio Usa
    Secretario
    8051 Brill Road
    Cincinnati Oh 45243
    Ohio Usa
    American64331710001
    CHAPMAN, Stephen Peter
    6 Thomas Crewe Close
    NN13 6DX Brackley
    Northamptonshire
    Director
    6 Thomas Crewe Close
    NN13 6DX Brackley
    Northamptonshire
    British24273740005
    CHAPMAN, Stephen Peter
    Nebethwaite House 12 Wold Road
    NN15 5PN Burton Latimer
    Northamptonshire
    Director
    Nebethwaite House 12 Wold Road
    NN15 5PN Burton Latimer
    Northamptonshire
    British24273740004
    DIXON, Joseph
    4688 State Route 132
    45103 Bratavia
    Ohio
    Usa
    Director
    4688 State Route 132
    45103 Bratavia
    Ohio
    Usa
    Us Citizen24247220002
    FALCOFSKY, Thomas
    10493 Stablehand Drive
    Cincinnati
    Oh 45242
    Usa
    Director
    10493 Stablehand Drive
    Cincinnati
    Oh 45242
    Usa
    American24247230002
    HORITA, Mark M
    3255 Wyndwicke Drive
    49085 St Joseph
    Michigan
    Usa
    Director
    3255 Wyndwicke Drive
    49085 St Joseph
    Michigan
    Usa
    American50135130001
    JOHNSEN, William Martin
    865 Rosewood Drive
    Villa Hills 41017
    Kentucky Usa
    Director
    865 Rosewood Drive
    Villa Hills 41017
    Kentucky Usa
    British54855330002
    KAHN, Richard
    111c Winding Way
    41011 Covington
    Kentucky
    Usa
    Director
    111c Winding Way
    41011 Covington
    Kentucky
    Usa
    American34588180002
    KENNY, Gregory
    4945 Burley Hills Drive
    ON 45243 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Director
    4945 Burley Hills Drive
    ON 45243 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Us Citizen68743440001
    MAHON, Jodi Lower
    7163 Northwich Drive
    45230 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Director
    7163 Northwich Drive
    45230 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    American50135390001
    MILLER, James Christopher
    27 Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EJ London
    Director
    27 Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EJ London
    United KingdomBritish1569600003
    ROPER, David Alexander
    Widbrook House
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    Director
    Widbrook House
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    British18379560003
    ROUNDHOUSE, Roger Alan
    3811 Red Fox Drive
    OH 45245 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Director
    3811 Red Fox Drive
    OH 45245 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Us Citizen66765030001
    SCANES, Derrick John
    Hillside Farm
    Irthlingborough Road, Little Addingt
    NN14 4AS Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Hillside Farm
    Irthlingborough Road, Little Addingt
    NN14 4AS Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish64275900001
    SCANES, Rodney Blake
    Monza House Irthlingborough Road
    Little Addington
    NN14 4AS Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Monza House Irthlingborough Road
    Little Addington
    NN14 4AS Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish24273750002
    SIVERD, Robert Joseph
    c/o General Cable Corporation
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    Kentucky
    4
    Ky 41076-9753
    U S A
    Director
    c/o General Cable Corporation
    Tesseneer Drive
    Highland Heights
    Kentucky
    4
    Ky 41076-9753
    U S A
    UsaUnited States64331710002
    TALIAFERRO, Elizabeth
    5600 Pamlico Lane
    OH 45243 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Director
    5600 Pamlico Lane
    OH 45243 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    American34588160001
    VIRGULAK, Christopher Francis
    8124 Starting Gate Lane
    FOREIGN Cincinnati Oh 45249
    Ohio Usa
    Director
    8124 Starting Gate Lane
    FOREIGN Cincinnati Oh 45249
    Ohio Usa
    American64331780002
    VIRGULAK, Christopher Francis
    8124 Starting Gate Lane
    FOREIGN Cincinnati Oh 45249
    Ohio Usa
    Director
    8124 Starting Gate Lane
    FOREIGN Cincinnati Oh 45249
    Ohio Usa
    American64331780002

    ¿Tiene GENERAL CABLE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Single debenture
    Creado el 07 jul 1994
    Entregado el 13 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1984
    Entregado el 09 feb 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See doc M10). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 feb 1984Registro de una carga
    • 05 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 22 jun 1983
    Entregado el 05 jul 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H, factory and outbuildings at refuge terrace, higham ferrers, northamptonshire NG9 8AZ.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jul 1983Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 21 ene 1983
    Entregado el 28 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over: undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & all fixtures uncalled capital, inc. Trade fixtures fixed plant & machinery & heritable property in scotland. (See doc M8).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1983Registro de una carga

    ¿Tiene GENERAL CABLE SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 jul 2016Inicio de la liquidación
    17 jun 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    William Kenneth Dawson
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Profesional
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0