JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01689995 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JAGUAR COMMUNICATIONS PLC | 24 abr 2008 | 24 abr 2008 |
| EASYBROOK LIMITED | 07 ene 1983 | 07 ene 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 30 nov 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 224 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 oct 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como secretario el 31 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Matthew Egan como director el 31 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como secretario el 31 may 2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 11 may 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven David Showell como director el 04 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| EGAN, Matthew | Director | Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 232755050001 | |||||||||
| SMITH, Neil Colin | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 204358750001 | |||||||||
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secretario | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secretario | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Secretario | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Lorraine | Secretario | 18b Denver Road N16 5JH London | British | 103543780001 | ||||||||||
| DROLET, Robert | Secretario | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Secretario | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152569550001 | |||||||||||
| RUSSELL, Gary Peter | Secretario | 9 Pirton Close AL4 9YJ St Albans Hertfordshire | British | 44428050001 | ||||||||||
| STOCKMAN, Richard Graham | Secretario | 3 Albert Street AL1 1RT St Albans Hertfordshire | British | 7490950001 | ||||||||||
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BEVERIDGE, Robert James | Director | 81 Kidmore Road Caversham RG4 7NQ Reading | United Kingdom | British | 62452090001 | |||||||||
| CLARKE, Gregory Allison | Director | Pinehurst Friary Road SL5 9HD Ascot Berkshire | British | 143319900001 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Director | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| COLEBROOK, Richard John | Director | 30 Prospect Lane AL5 2PL Harpenden Hertfordshire | England | United Kingdom | 2606430002 | |||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Director | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | 122128470002 | |||||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Director | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135958960001 | |||||||||
| DROLET, Robert | Director | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| FITZ, Joseph Daniel | Director | 35 Aria House 5-15 Newton Street Covent Garden WC2B 5EN London | British | 70579740002 | ||||||||||
| GARARD, Andrew Sheldon | Director | Waldegrave House 293 Waldegrave Road TW1 4SU Twickenham Middlesex | British | 69630190003 | ||||||||||
| GIBSON, Ian Jeffrey | Director | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | 78528840005 | |||||||||
| HEWITT, Martin Robert | Director | 46 Milliners Court Lattimore Road AL1 3XT St. Albans Hertfordshire | British | 2606450004 | ||||||||||
| HOGGARTH, Royston | Director | The Barley House Hawks Meadow Snowford Hall Farm CV33 9ES Hunningham Warwickshire | England | British | 67927330001 | |||||||||
| JAMES, Kevin | Director | 6 Maxwell Close WD3 2BR Rickmansworth Hertfordshire | British | 55357740001 | ||||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Director | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||||||
| KINCH, Alan Royston | Director | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 163334420001 | |||||||||
| LERWILL, Robert Earl | Director | Water Street WC2R 3LA London 1 | British | 51239200003 | ||||||||||
| MOLYNEUX, Mary Bridget | Director | 33 Saint Jamess Gardens W11 4RF London | Australian | 63615470001 | ||||||||||
| NORTON, Graham Howard | Director | Storrs Hill Cottage White Rose Lane GU22 7LB Woking Surrey | British | 91014890001 | ||||||||||
| PHILLIP, Kerry | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 185033430001 | |||||||||
| QUINN, Peter Herbert | Director | Dog House HP5 1UQ Latimer Buckinghamshire | British | 663570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless U.K. | 06 abr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 29 abr 2002 Entregado el 07 may 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creado el 01 mar 1996 Entregado el 11 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 08 feb 1993 Entregado el 11 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £19,839.47 | |
Breve descripción All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 13 feb 1991 Entregado el 02 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £19290.36 | |
Breve descripción All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattles mortgage | Creado el 04 jun 1990 Entregado el 06 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 ene 1986 Entregado el 29 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 jun 1985 Entregado el 04 jul 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0