JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01689995
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JAGUAR COMMUNICATIONS PLC24 abr 200824 abr 2008
    EASYBROOK LIMITED07 ene 198307 ene 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 nov 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 14/11/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2017

    16 páginasAA

    legacy

    224 páginasPARENT_ACC

    Declaración de confirmación presentada el 25 oct 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cese del nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017

    2 páginasAP02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 páginasAD04

    Cese del nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como secretario el 31 may 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Matthew Egan como director el 31 may 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como secretario el 31 may 2017

    2 páginasAP04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 11 may 2016

    • Capital: GBP 1,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 22/04/2016
    RES13

    Cese del nombramiento de Steven David Showell como director el 04 ene 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    EGAN, Matthew
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    Director
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish232755050001
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secretario
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secretario
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Secretario
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    DAVIDSON, Lorraine
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    Secretario
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    British103543780001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Secretario
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152569550001
    RUSSELL, Gary Peter
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    British44428050001
    STOCKMAN, Richard Graham
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    British7490950001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2357692
    75473330004
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Director
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Director
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Director
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEBROOK, Richard John
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom2606430002
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Director
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Director
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    FITZ, Joseph Daniel
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    Director
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    British70579740002
    GARARD, Andrew Sheldon
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    Director
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    British69630190003
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    HEWITT, Martin Robert
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    British2606450004
    HOGGARTH, Royston
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    Director
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    EnglandBritish67927330001
    JAMES, Kevin
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British55357740001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Director
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    LERWILL, Robert Earl
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    Director
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    British51239200003
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Director
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    NORTON, Graham Howard
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    Director
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    British91014890001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    QUINN, Peter Herbert
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    Director
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    British663570001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaUnlimited With Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1541957
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 29 abr 2002
    Entregado el 07 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account.
    Personas con derecho
    • Euroinvest Estates Limited
    Transacciones
    • 07 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 01 mar 1996
    Entregado el 11 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Credit agreement
    Creado el 08 feb 1993
    Entregado el 11 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £19,839.47
    Breve descripción
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 11 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 13 feb 1991
    Entregado el 02 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £19290.36
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 02 feb 1991Registro de una carga
    • 29 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattles mortgage
    Creado el 04 jun 1990
    Entregado el 06 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 06 jun 1990Registro de una carga
    • 10 sept 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 ene 1986
    Entregado el 29 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1986Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 27 jun 1985
    Entregado el 04 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0