01711457 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | 01711457 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01711457 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | Sí |
¿Cuál es el propósito de 01711457 LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra 01711457 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 01711457: COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 01711457 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PREMIER PERCUSSION LIMITED | 13 ago 1984 | 13 ago 1984 |
| REFAL 76 LIMITED | 31 mar 1983 | 31 mar 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de 01711457 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2006 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para 01711457 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 01711457: Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 23 may 2022 | 1 páginas | RP05 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Restauración por orden judicial | 4 páginas | AC92 | ||
Certificado de cambio de nombre Company name changed fifield\certificate issued on 26/07/16 | páginas | CERTNM | ||
Una selección de documentos registrados antes del 1 de enero de 1995 | 116 páginas | PRE95 | ||
Una selección de documentos registrados antes del 1 de enero de 1987 | páginas | PRE87 | ||
Constitución | 27 páginas | NEWINC | ||
¿Quiénes son los directivos de 01711457 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMS, Nigel Philip Benford | Secretario | Cottage Rolleston Leicestershire LE7 9EN Home Farm United Kingdom | British | 124405080002 | ||||||
| SIMS, Nigel Philip Benford | Director | Cottage Rolleston Leicestershire LE7 9EN Home Farm United Kingdom | British | 124405080002 | ||||||
| SPEIRS, William Blake, Professor | Director | The Cornmill Calver S32 3WW Sheffield | England | British | 13196350001 | |||||
| BARTON, Anthony Dale | Secretario | 24 Tithby Road Bingham NG13 8GN Nottingham | British | 35928490001 | ||||||
| KOCHI, Akira | Secretario | 104 Leicester Road Glen Parva LE2 9HF Leicester Leicestershire | Japanese | 15431140001 | ||||||
| MCLOUGHLIN, Michael John | Secretario | 8 Southland Road LE2 3RJ Leicester Leicestershire | British | 15431200001 | ||||||
| MCQUIRE, Michael Charles | Secretario | 80 Chiltern Avenue LE9 1UF Cosby Leicestershire | British | 99292820001 | ||||||
| SIMS, Nigel Philip Benford | Secretario | Church Farm House Wormleighton CV47 2XV Southam Warwickshire | British | 96911300001 | ||||||
| THOMS, Peter Young | Secretario | 1 Beechwood Drive KT11 2DX Cobham Surrey | British | 19514010001 | ||||||
| BARKATAKI, Dwijendra Chandra | Director | 43 Cambridge Road Little Abingdon CB1 6BL Cambridge Cambridgeshire | British | 44859750001 | ||||||
| BARTON, Anthony Dale | Director | 24 Tithby Road Bingham NG13 8GN Nottingham | British | 35928490001 | ||||||
| DOUGHTY, Tony William | Director | Cobblers Cottage 9 Clements Gate Diseworth DE74 2QE Derby N.W Leicestershire | British | 41786120001 | ||||||
| GOTO, Mitsumasa | Director | C/O Yamaha Corporation 10-1 Nakasawa-Cho P O Box 1 FOREIGN Hamamatsu 301 Japan | Japanese | 15431160001 | ||||||
| GOULD, Paul | Director | 1 Holbeck Drive Broughton Astley LE9 6UR Leicestershire | British | 49535720001 | ||||||
| HEARN, Ian Paul | Director | 1 Hawthorne Drive LE5 6DL Leicester Leicestershire | British | 15431170001 | ||||||
| ITO, Shoji | Director | C/O Yamaha Corporation Of Europe Ltd Trafalgar House 2 Chalkhill Road W6 6DU London | Japanese | 15937450001 | ||||||
| JAMES, John Henry | Director | Hampnett Manor GL54 3NW Cheltenham Gloucs | British | 123464950001 | ||||||
| JORDAN, Stephen Thomas | Director | 1 Trevor Close Tile Hill Village CV4 9HP Coventry West Midlands | English | 35928500001 | ||||||
| KAJI, Yoshiro | Director | Yamaha Corporation 10-1 Nakazawa-Cho FOREIGN Hamamatsu 430 Japan | Japanese | 22260730001 | ||||||
| KOCHI, Akira | Director | 104 Leicester Road Glen Parva LE2 9HF Leicester Leicestershire | Japanese | 15431140001 | ||||||
| KUROE, Tsuneo | Director | Flat 119 Chelsea Cloisters SW3 3DW Sloane Avenue London | Japanese | 13069420002 | ||||||
| MCLOUGHLIN, Michael John | Director | 8 Southland Road LE2 3RJ Leicester Leicestershire | British | 15431200001 | ||||||
| VIZOR, Jon Stuart | Director | Bredon School Lane Lower Brailes OX15 5HP Banbury Oxfordshire | British | 42401700001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0