ABC12345678 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaABC12345678 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01726611
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ABC12345678 LIMITED?

    • (5212) /

    ¿Dónde se encuentra ABC12345678 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hillcairnie House
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Worcestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ABC12345678 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WINSTONMEAD LIMITED26 may 201026 may 2010
    WINSTONMEAD PLC25 may 198325 may 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ABC12345678 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABC12345678 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginas4.72

    Domicilio social registrado cambiado de Aston House 5 Aston Road North Aston Birmingham West Midlands B6 4DS a Hillcairnie House St. Andrews Road Droitwich Worcestershire WR9 8DJ el 01 oct 2015

    1 páginasAD01

    Restauración por orden judicial

    2 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    20 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 mar 2013

    18 páginas4.68

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    3 páginasF10.2

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de * 4 Palace Avenue Paignton Devon TQ3 3HA United Kingdom* el 26 mar 2012

    2 páginasAD01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed winstonmead LIMITED\certificate issued on 24/02/12
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    24 feb 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Domicilio social registrado cambiado de * Ranger House Etruria Road Stoke on Trent Staffordshire ST1 5NH* el 26 ene 2012

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Adrian Hensby como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Morris como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Morris como secretario

    2 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG04

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 dic 2010

    17 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2011 au 31 dic 2010

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Stephen Mark Perry como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Holdcroft como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Deborah Haynes como director

    2 páginasTM01

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 26 may 2011

    8 páginas1.3

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    7 páginas1.4

    ¿Quiénes son los directivos de ABC12345678 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUNT, Cliff
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    Director
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    EnglandBritishCommercial Director136015580001
    PERRY, Stephen Mark
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    Director
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector87696020003
    BATER, Richard James
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    British55321500003
    HENSBY, Lucy Ann
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    Secretario
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    BritishDirector86508100003
    KNIGHT, Toni Suzanne
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    British64520590004
    MORRIS, Robert
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Secretario
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    British150891220001
    ROBERTSON, Sheila Josephine
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Secretario
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    British4784580001
    BALL, Andrew
    The Edge
    Bay Hill St Margarets Bay
    CT15 6DU Dover
    Kent
    Director
    The Edge
    Bay Hill St Margarets Bay
    CT15 6DU Dover
    Kent
    EnglandBritishDirector69112930003
    BATER, Richard James
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    Director
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    BritishAccountant55321500002
    BUTCHER, Matthew
    7 Pargeters Hyam
    SS5 4EA Hockley
    Essex
    Director
    7 Pargeters Hyam
    SS5 4EA Hockley
    Essex
    United KingdomBritishSales Director46227480003
    DESBOIS, Roderick
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishSales Director164467240001
    DOULTON, Mark Daryl
    Castle Road
    SS6 7HT Rayleigh
    3
    Essex
    England
    Director
    Castle Road
    SS6 7HT Rayleigh
    3
    Essex
    England
    BritishSales Director85426170003
    HAYNES, Deborah
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector62319730003
    HENSBY, Adrian Trevor
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector110016540002
    HENSBY, Benjamin Thomas, Director Of Operations
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector Of Operations129048800002
    HENSBY, Lucy Ann
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    Director
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    United KingdomBritishDirector86508100004
    HENSBY, Lucy Ann
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    Director
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    BritishDirector86508100003
    HOLDCROFT, Philip
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector62319640002
    KNIGHT, Toni Suzanne
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector64520590004
    MORRIS, Robert
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Director
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector63073600002
    PAXTON, Teri Louise
    169 Grove Road
    SS6 8UA Rayleigh
    Essex
    Director
    169 Grove Road
    SS6 8UA Rayleigh
    Essex
    BritishDirector75563490001
    ROBERTSON, Alexander Clifford
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Director
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishDirector24291610001
    ROBERTSON, Sheila Josephine
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Director
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    BritishDirector/Secretary4784580001
    TAYLOR, David Simon
    6 The South Stables
    Historic Dockyard
    ME4 4QX Chatham
    Essex
    Director
    6 The South Stables
    Historic Dockyard
    ME4 4QX Chatham
    Essex
    BritishOperations Director112701020001
    WILSHER, Phillip
    50 Crown Hill
    SS6 7FR Rayleigh
    19 The Trinity
    Essex
    Director
    50 Crown Hill
    SS6 7FR Rayleigh
    19 The Trinity
    Essex
    EnglandBritishSales Director140370800001

    ¿Tiene ABC12345678 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 jul 2010
    Entregado el 28 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 07 oct 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Floating charge (all assets)
    Creado el 03 jun 2008
    Entregado el 06 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 06 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 28 jul 2005
    Entregado el 29 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 29 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 abr 2005
    Entregado el 29 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 29 jul 1993
    Entregado el 09 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Part of the ground floor of the building k/a premises on the east side of bentalls, pipps hill industrial area, basildon, essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 09 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 abr 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 20 abr 1991
    Entregado el 04 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that part of the ground floor of the building k/a premises on the east side of bentalls pupps hill industrial area basildon essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 04 may 1991Registro de una carga
    • 25 abr 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 21 jun 1988
    Entregado el 24 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed charge on book & other debts present & future and the proceeds thereof as are not sold to & bought by alex lawrie receivables financing limited under the terms of an agreement of even date (see 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Alex Lawrie Receivable Financing Limited
    Transacciones
    • 24 jun 1988Registro de una carga
    • 06 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 23 dic 1986
    Entregado el 30 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1986Registro de una carga
    • 20 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ABC12345678 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 feb 2010Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    26 may 2011Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    William Matthew Humphries Tait
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    David Harry Gilbert
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    FechaTipo
    21 feb 2017Fecha de disolución
    19 mar 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Aston House 5 Aston Road North
    Aston
    B6 4DS Birmingham
    Profesional
    Aston House 5 Aston Road North
    Aston
    B6 4DS Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0