SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED

SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01736752
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 abr 2012

    Estado de capital el 20 abr 2012

    • Capital: GBP 4,606
    SH01
    X178B5PK

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A16QG2MX

    Nombramiento de Mr Colin Blebta como director el 26 sept 2011

    2 páginasAP01
    XUNZ7XVC

    Cese del nombramiento de Hubertus Antonius Wijnand Wijnen como director el 26 sept 2011

    1 páginasTM01
    XUNXEXVH

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA
    AE74YX60

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    XD0DPTBG

    Cambio de datos del director Mr Kerry James Mcdonagh el 15 abr 2011

    2 páginasCH01
    XD0DNTBE

    Cambio de datos del secretario Mr Peter John Simmonds el 15 abr 2011

    1 páginasCH03
    XD0DMTBD

    Cambio de datos del director Mr Hubertus Antonius Wijnand Wijnen el 15 abr 2011

    2 páginasCH01
    XD0DOTBF

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA
    A5H4VNN5

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    XGMVMJ43

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA
    RXCJMCDU

    legacy

    4 páginas363a
    X9E2J9ES

    legacy

    1 páginas288c
    XR7ZI7FY

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    1 páginasAA
    AK2H02WB

    legacy

    1 páginas288c
    XMKRL2GX

    legacy

    7 páginas363s
    AVB1P0GM

    legacy

    1 páginas288a
    A1QNWYQ8

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    1 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SIMMONDS, Peter John
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    Secretario
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    BritishCompany Executive108212170001
    BLEBTA, Colin
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    Director
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    EnglandBritishCompany Executive93805030001
    MCDONAGH, Kerry James
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    Director
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    United KingdomBritishCompany Executive124716920002
    EVANS, Ceri
    Coed Glas
    Talygarn
    CF7 9JU Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Secretario
    Coed Glas
    Talygarn
    CF7 9JU Pontyclun
    Mid Glamorgan
    British18785940001
    BEST, Peter Michael
    2 Clent Drive
    DY9 9LN Hagley
    West Midlands
    Director
    2 Clent Drive
    DY9 9LN Hagley
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Executive125898570001
    BOWDEN, Alan John
    Magor Court Newport Road
    Magor
    NP6 3BZ Newport
    Gwent
    Director
    Magor Court Newport Road
    Magor
    NP6 3BZ Newport
    Gwent
    BritishCompany Director9042180001
    EVANS, Ceri
    Coed Glas
    Talygarn
    CF7 9JU Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Director
    Coed Glas
    Talygarn
    CF7 9JU Pontyclun
    Mid Glamorgan
    BritishChartered Accountant18785940001
    FRASER, Kenneth
    13 Nottadge Road
    Mumbles
    SA3 Swansea
    West Glam
    Director
    13 Nottadge Road
    Mumbles
    SA3 Swansea
    West Glam
    BritishCompany Director18785920002
    FREEMAN, Richard Robert
    The Orchards
    Ardens Grafton
    B49 6DR Alcester
    Warwickshire
    Director
    The Orchards
    Ardens Grafton
    B49 6DR Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Executive53170800002
    GEUECKE, Wolfgang Dieter
    Rulaenderstr. 22
    Mainz
    55129
    Germany
    Director
    Rulaenderstr. 22
    Mainz
    55129
    Germany
    GermanCompany Executive74668400002
    HOFMANN, Thorsten
    11 Norfolk House
    Courtlands
    TW10 5AT Richmond
    Surrey
    Director
    11 Norfolk House
    Courtlands
    TW10 5AT Richmond
    Surrey
    GermanCompany Executive58392680002
    KIRBY, Philip John
    Twingates Rogers Lane
    Laleston
    CF32 0LA Bridgend
    Mid Glamorgan
    Director
    Twingates Rogers Lane
    Laleston
    CF32 0LA Bridgend
    Mid Glamorgan
    British62788210001
    MAHNEL, Andreas Johannes
    Yorkstrasse 16
    Aschaffenburg
    63739
    Germany
    Director
    Yorkstrasse 16
    Aschaffenburg
    63739
    Germany
    GermanCompany Executive77851140001
    STURM, Frank Ludwig
    Flat 20 The Byfrons
    Boundary Road
    GU14 6SE Farnborough
    Hampshire
    Director
    Flat 20 The Byfrons
    Boundary Road
    GU14 6SE Farnborough
    Hampshire
    GermanCompany Executive43871740001
    WIJNEN, Hubertus Antonius Wijnand
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    Director
    Kingsclere Road
    Basingstoke
    RG21 6XJ Hampshire
    United KingdomDutchCompany Executive129522090004
    YOUNG, Brian Henry
    Broadyard Church Lane
    Bearley
    CV37 0SL Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    Broadyard Church Lane
    Bearley
    CV37 0SL Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director6194400001

    ¿Tiene SEVERNSIDE MECHANICAL HANDLING GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over sub-hire agreement
    Creado el 11 ene 1995
    Entregado el 01 feb 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined therein) as from time to time varied extended or replaced
    Breve descripción
    All the rights title and interest of the company in respect of the charged agreement being reference number B170194 and dated the 8 july 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Humberclyde Assets Limited
    Transacciones
    • 01 feb 1995Registro de un cargo (395)
    Collateral debenture
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 29 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from filbuk 362 limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 30 jun 1993
    Entregado el 01 jul 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master agreement dated 6 august 1990 and all other monies payable under all other hire-purchase agreements
    Breve descripción
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods.all monies payable.the benefit of all guarantees,indemnities and other securities.the benefit of all insurances.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 01 jul 1993Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 26 mar 1993
    Entregado el 08 abr 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit C7 north road bridgend industrial estate bridgend mid glamorgan and the proceeds of sale thereof and an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1993Registro de un cargo (395)
    Assignment of deposit account moneys
    Creado el 09 jul 1992
    Entregado el 14 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assignment of the sum of £310,000 or such sum or such part thereof.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 14 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 02 ene 1992
    Entregado el 14 ene 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/as unit 2,4,6,8,10,12,14,16,18 and 20 blaenwern,cwmbran the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 1992Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 02 ene 1992
    Entregado el 14 ene 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/as piece or parcel of land with buildings erected thereon situate at beaufort road plasmarl swansea enterprise park swansea the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 1992Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 nov 1991
    Entregado el 29 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 13 feb 1991
    Entregado el 05 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property described in the schedule to the mortgage deed - please refer to form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 mar 1991Registro de una carga
    • 11 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 dic 1989
    Entregado el 14 dic 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to humberclyde industrial finance limited under terms of any hire purchase conditioned sale or leasing agreements (as from time to time varied extended or replaced)
    Breve descripción
    The rights title benefits and interest of severnside mechanical handling group LTD in respect of leasing hiring agreements (see form 395 for details).
    Personas con derecho
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transacciones
    • 14 dic 1989Registro de una carga
    Chattel mortgage
    Creado el 14 nov 1989
    Entregado el 23 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Please see schedule attached to form 395 comprising of 10 pages.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 nov 1989Registro de una carga
    • 14 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 nov 1989
    Entregado el 17 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property k/as units 2,4,6,8,10,12,14,16,18 and 20 blaenwern, cwmbran gwent. All that l/h property situate l/h property situate at beaufort road plasmare. Swansea enterprise park, swansea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 17 nov 1989Registro de una carga
    • 20 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1989
    Entregado el 21 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The land and premises at beaufort road plasmarl,swansea enterprise park,swanseawest glamorgan t/no wa 395384.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jun 1989Registro de una carga
    • 11 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 02 jun 1989
    Entregado el 07 jun 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that piece of land together with the buildings thereon situate at beaufort road plasmarl swansea enterprise park swansea together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon & therein.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 07 jun 1989Registro de una carga
    Fixed charge
    Creado el 03 feb 1989
    Entregado el 13 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title & interest of the company in a) all hiring, leasing & hire purchase agreements b) all securities c) the chattels.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 feb 1989Registro de una carga
    • 14 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Schedule supplementary to a deed of charge
    Creado el 14 oct 1988
    Entregado el 15 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of a first fixed charge all the rights and interest of the company with hire agreements. (See form 395 for detaill).
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Leasing Co.
    Transacciones
    • 15 oct 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 08 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 1 beaufort road, plasmarl industrial estate, swansea, west glam.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1988Registro de una carga
    • 14 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Schedule
    Creado el 02 jun 1988
    Entregado el 08 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement (as defined) and this charge.
    Breve descripción
    1ST fixed charge allits rights and interest in the hire agreements listed with the rights of the company under securities. Date of sub-hire agreement 13/05/88 inco europe limited/nissan APHO2A250 chan so 000320. clydach/nissan APH02A25U chas no 000352 swansea/nissan CYM02125U chas no 001082 west glam/nissan UGFO3A50TU chas no 000576 SA65QR/nissan UGFO3A40TU chas no J000355(please see doc for full details).
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Leasing Co. Limited.
    Transacciones
    • 08 jun 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 02 jun 1988
    Entregado el 08 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement (as defined) and this charge.
    Breve descripción
    1ST fixed charge all its rights and interest in (1) such hire agreements made by the company in respect of goods supplied to the company on hsl on credit hire sale of return or otherwise as on previously now or hereafter entered on by the company shown in supplementary schedules. (Please see doc 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Leasing Co Limited
    Transacciones
    • 08 jun 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 13 may 1988
    Entregado el 17 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to midland mortgage leasing limited as agent for the (18) chargees named on the attached schedule under the terms of any lease purchase agreement, bailment, agreement or this charge
    Breve descripción
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof between severnside mechanical handling group limited nd a preson to whom severnside mechanical handling group limited. Lets or agrees to let goods framing the subtech matter of any hire purchase agreement or bailment agreement refered to (please see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Montagu Leasing (UK) Limited
    • Midland Montagu Leasing (GB) Limited
    • Forward Leasing (Broad Street) Limited
    • Forward Leasing Limited
    • Midland Montagu Leasing Limited
    • Forward Leasing (B) Limited
    • Midland Montagu Equipment Finance Limited
    • Forward Leasing (D) Limited
    • Midland Gillett Leasing (South) Limited
    • Midland Montagu Leasing (Af) Limited
    • Forward Leasing (Af) Limited
    • Midland Montagu Equipment Finance (UK) Limited
    • Midland Montagu Leasing (D) Limited
    • Forward Leasing (C) Limited
    • Forward Leasing (GB) Limited
    • Midland Montagu Leasing (B.S.H) Limited
    • Midland Montagu Leasing (B) Limited
    • Midland Montagu Leasing (C) Limited
    • Forward Leasing (UK) Limited
    Transacciones
    • 17 may 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Master agreement & charge
    Creado el 06 may 1988
    Entregado el 17 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any hire purchase agreement, conditional sale agreement or bailment agreement (as defined) or this charge
    Breve descripción
    All sub-hiring agreements both present and future letting goods owned by the chargee and all associated choses in ACTIO9N righjts and securities (charged assets) (see form 395 for further details).
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 17 may 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 29 feb 1988
    Entregado el 15 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of leasing agreement d/d 29.2.88
    Breve descripción
    All such rights, title benefit and interest which the company may now or in the future have in & to all monies payable to it under or in correction with all or any leases of hirings of the equipment (please see form 355 for full details).
    Personas con derecho
    • Lease Management Services Limited
    Transacciones
    • 15 mar 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 22 dic 1987
    Entregado el 04 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All rights title benefit and interest which severnside mechanical handling group limited may now or in the future have in and to all monies (including rentals) payable under or in connection with the leasing agreement dated 22.12.87. (see doc for full details).
    Personas con derecho
    • Lease Management Services Limited
    Transacciones
    • 04 ene 1988Registro de una carga
    • 20 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 oct 1987
    Entregado el 08 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that land and industrial building atboth beaufort road on the plasmarl industrial estate, swansea having an area of 1.2 acres.
    Personas con derecho
    • First National Securities Limited
    Transacciones
    • 08 oct 1987Registro de una carga
    • 14 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 02 sept 1987
    Entregado el 02 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the leases
    Breve descripción
    All the rights, titles, benefits & interests of the company whatsoever, present & future whether proprietary, contractual or otherwise under or arising out of or in respect of (1) the agreements listed in schedule 1 to the charge ("the agreements").
    Personas con derecho
    • Milestone Leasing Limited
    Transacciones
    • 02 sept 1987Registro de una carga
    • 17 jul 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0