IN-TO-SAVE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIN-TO-SAVE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01739084
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IN-TO-SAVE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra IN-TO-SAVE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IN-TO-SAVE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IN-TO-SAVE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Zane Cedomir Mersich el 11 ene 2022

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Zane Cedomir Mersich el 22 sept 2020

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB el 13 jul 2020

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England a Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB el 16 mar 2020

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Neil Paramore como director el 28 ene 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Paramore como secretario el 28 ene 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Andrew Mark Glennon como secretario el 28 ene 2020

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Andrew Mark Glennon como director el 28 ene 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 jun 2016

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de IN-TO-SAVE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Secretario
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960810001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Director
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Director
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Secretario
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Secretario
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    British7148530001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Secretario
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209558860001
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965340002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secretario corporativo
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BOGG, Dyson Peter Kelly
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Director
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Australian113701350003
    BRYDON, Leslie
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    Director
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    British103621720001
    EVANS, Byron
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    Director
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    British105734100001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Director
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    United KingdomBritish7148530001
    HUGHES, John Ashley
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    Director
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish112694600001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Director
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Director
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IN-TO-SAVE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06 abr 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05382157
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene IN-TO-SAVE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 04 abr 2007
    Entregado el 17 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transacciones
    • 17 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 08 feb 2007
    Entregado el 14 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 jul 2005
    Entregado el 09 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 may 1998
    Entregado el 30 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creado el 09 sept 1996
    Entregado el 17 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the standard security
    Breve descripción
    The plot or area of ground lying in the burgh of kirkcaldy and county of fife extending to 865 square metres bounded on or twoards the southwest by whytescauseway, kirkcaldy along which it extends 15.3 metres.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 17 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 ago 1994
    Entregado el 10 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from leisure promotions limited to the chargee on any accouny whatsoever and by the company under the provisions of the charge
    Breve descripción
    Land and buildings on south side of boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 ago 1994
    Entregado el 10 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 21 jul 1994
    Entregado el 22 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 sept 1992
    Entregado el 02 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 ref M366C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 ene 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 06 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 27 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit G3, boathouse lane stockton-on-tees cleveland title no ce 76294.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 mar 1991Registro de una carga
    • 16 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 jun 1988
    Entregado el 22 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees cleveland. Title no ce 60319.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 1988Registro de una carga
    • 16 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 10 sept 1984
    Entregado el 14 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 1984Registro de una carga
    • 16 ene 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 06 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0