OLYMPIC-CHEVIN LIMITED

OLYMPIC-CHEVIN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOLYMPIC-CHEVIN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01761091
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 18 sept 2014

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 oct 2013

    Estado de capital el 04 oct 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Martyn Richard Powell el 24 oct 2011

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director David White el 24 oct 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Martyn Richard Powell el 24 oct 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2007

    3 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2006

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de OLYMPIC-CHEVIN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    POWELL, Martyn Richard
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Secretario
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    British38707060002
    POWELL, Martyn Richard
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Director
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant38707060002
    WHITE, David
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Director
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant1596440002
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant72559760001
    LYNE, Colin Andrew
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    Secretario
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    BritishDirector49615160001
    PERCIVAL, Peter William Scott
    16 Roland Way
    SW7 3RE London
    Secretario
    16 Roland Way
    SW7 3RE London
    British394640001
    THEO, Philip Christopher
    18 Roundhead Fold
    Apperley Bridge
    BD10 0UG Bradford
    West Yorkshire
    Secretario
    18 Roundhead Fold
    Apperley Bridge
    BD10 0UG Bradford
    West Yorkshire
    BritishSecretary64218980002
    WINTERS, Geoffrey David
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    Secretario
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    BritishCompany Director42524380002
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant72559760001
    COOLEY, David Raymond
    3 Glentworth Road
    Clifton
    BS8 4TB Bristol
    Director
    3 Glentworth Road
    Clifton
    BS8 4TB Bristol
    EnglandBritishDirector85506380001
    DEVINE, Andrew Neal
    84 Lamplighter Close
    Hampstead
    ME7 1DX Gillingham
    Kent
    Director
    84 Lamplighter Close
    Hampstead
    ME7 1DX Gillingham
    Kent
    BritishDirector32495870002
    DIXON, Mark Robert Graham
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    Director
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    United KingdomBritishDirector51467220003
    FREEMAN, Michael John
    Old Forge Cottage
    Windsor Holloway Whitington Kinver
    DY7 6NS Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Old Forge Cottage
    Windsor Holloway Whitington Kinver
    DY7 6NS Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector1596480001
    HALVORSEN, Thomas Barry
    33 The Whartons
    LS21 2AG Otley
    West Yorkshire
    Director
    33 The Whartons
    LS21 2AG Otley
    West Yorkshire
    BritishDirector32495850001
    JOHNSON, Richard Stuart
    Braxfield House
    Charingworth
    GL55 6XU Chipping Campden
    Gloucestershire
    Director
    Braxfield House
    Charingworth
    GL55 6XU Chipping Campden
    Gloucestershire
    BritishCompany Director6420800001
    LINK, Wilfred Alan
    Carron House 64 Aldridge Road
    Little Aston
    WS9 0PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Carron House 64 Aldridge Road
    Little Aston
    WS9 0PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector45359550002
    LYNE, Colin Andrew
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    Director
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director49615160001
    PINDER, David John
    7 Wyfold Cottages
    RG4 9HX Wyfold
    South Oxfordshire
    Director
    7 Wyfold Cottages
    RG4 9HX Wyfold
    South Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector154168880001
    THEO, Philip Christopher
    18 Roundhead Fold
    Apperley Bridge
    BD10 0UG Bradford
    West Yorkshire
    Director
    18 Roundhead Fold
    Apperley Bridge
    BD10 0UG Bradford
    West Yorkshire
    BritishSecretary64218980002
    WHITE, Philip Ernest James
    Ryton House
    Ryton
    TF11 9JJ Shifnal
    Salop
    Director
    Ryton House
    Ryton
    TF11 9JJ Shifnal
    Salop
    BritishCompany Director1688370001
    WINTERS, Geoffrey David
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    Director
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    BritishDirector42524380002

    ¿Tiene OLYMPIC-CHEVIN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession certificate
    Creado el 26 ene 1996
    Entregado el 01 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of an agreement dated 31ST july 1992
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Accession certificate
    Creado el 04 oct 1995
    Entregado el 20 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Transfer deed
    Creado el 12 ago 1993
    Entregado el 01 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 abr 1993
    Entregado el 22 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 22 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 abr 1993
    Entregado el 22 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 22 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 02 abr 1993
    Entregado el 13 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock instrument and the stock or by the chargor under the guarantee and debenture on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details see form 395 and cont sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Accession certificate
    Creado el 11 feb 1993
    Entregado el 03 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the accession certificate as defined therein
    Breve descripción
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the accession certificate as defined.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Accession certificate
    Creado el 31 jul 1992
    Entregado el 18 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the security documents
    Breve descripción
    See form 395 ref M123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creado el 23 oct 1991
    Entregado el 25 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date.
    Breve descripción
    The sum of £8474.50.
    Personas con derecho
    • Banque Arabe Et Internationale D Investssemont
    Transacciones
    • 25 oct 1991Registro de una carga
    • 02 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 11 oct 1991
    Entregado el 22 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Breve descripción
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge for details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1991Registro de una carga
    • 03 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene OLYMPIC-CHEVIN LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 sept 2014Inicio de la liquidación
    25 feb 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0