H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED

H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaH. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01762017
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    • (1771) /

    ¿Dónde se encuentra H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOWERBRACE SERVICES LIMITED17 oct 198317 oct 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 27 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 jul 2011

    Estado de capital el 20 jul 2011

    • Capital: GBP 100,052.34
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2010

    5 páginasAA

    Resumen de ingresos y gastos del administrador hasta 26 oct 2010

    5 páginas2.15

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    5 páginas1.4

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2009 au 30 jun 2010

    3 páginasAA01

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2010

    8 páginas1.3

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    15 páginasAA

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2009

    6 páginas1.3

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    13 páginasAA

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2009

    5 páginas1.3

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2009

    2 páginas1.3

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    15 páginasAA

    legacy

    9 páginas363s

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2007

    10 páginas1.3

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 20 mar 2007

    2 páginas1.3

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    19 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    6 páginas363a

    legacy

    7 páginas395

    ¿Quiénes son los directivos de H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FLUDE, Simon Harry
    88 One Fletcher Gate
    Adam Walk
    NG1 1QR Nottingham
    Notts
    Director
    88 One Fletcher Gate
    Adam Walk
    NG1 1QR Nottingham
    Notts
    EnglandBritishCompany Director11848840003
    HIGGINS, Malcolm John
    Framland Main Street
    Thurlaston
    LE9 7TP Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    Framland Main Street
    Thurlaston
    LE9 7TP Leicester
    Leicestershire
    British46540170001
    JUDD, Ivan
    47 The Ridgeway
    Burbage
    LE10 2NR Hinckley
    Leicestershire
    Secretario
    47 The Ridgeway
    Burbage
    LE10 2NR Hinckley
    Leicestershire
    British27230610001
    MUTIMER, Nigel Barrington
    1 Jacquemart Close
    LE67 4QP Coalville
    Leicestershire
    Secretario
    1 Jacquemart Close
    LE67 4QP Coalville
    Leicestershire
    British12347700001
    HARVEY INGRAM SECRETARIES LIMITED
    20 New Walk
    LE1 6TX Leicester
    Leicestershire
    Secretario corporativo
    20 New Walk
    LE1 6TX Leicester
    Leicestershire
    99462280001
    BURROWS, Roger Alan
    46 Westfield Road
    Hinckley
    LE10 0QW Leicester
    Leicestershire
    Director
    46 Westfield Road
    Hinckley
    LE10 0QW Leicester
    Leicestershire
    BritishTechnical Manager37569390001
    FLUDE, Cedric Terence
    Oakwood Grange Barton Road
    Market Bosworth
    CV13 0LQ Nuneaton
    Warwickshire
    Director
    Oakwood Grange Barton Road
    Market Bosworth
    CV13 0LQ Nuneaton
    Warwickshire
    BritishCompany Director11848830001
    GREEN, Mark Quentin Toye
    37 Villiers Avenue
    KT5 8BB Surbiton
    Surrey
    Director
    37 Villiers Avenue
    KT5 8BB Surbiton
    Surrey
    BritishMarketing & Sales Director67211440002
    HIGGINS, Malcolm John
    Framland Main Street
    Thurlaston
    LE9 7TP Leicester
    Leicestershire
    Director
    Framland Main Street
    Thurlaston
    LE9 7TP Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant46540170001
    HOWARD, Raymond
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    Director
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector1470930001
    JUDD, Ivan
    47 The Ridgeway
    Burbage
    LE10 2NR Hinckley
    Leicestershire
    Director
    47 The Ridgeway
    Burbage
    LE10 2NR Hinckley
    Leicestershire
    BritishSales Manager27230610001
    PATRICK, Elizabeth
    De Noveray House
    Rectory End
    LE8 9DR Burton Overy
    Leicester
    Director
    De Noveray House
    Rectory End
    LE8 9DR Burton Overy
    Leicester
    BritishCompany Director11522290001
    WATERS, George Arthur
    19 The Meadway
    Birstall
    LE4 4NG Leicester
    Leicestershire
    Director
    19 The Meadway
    Birstall
    LE4 4NG Leicester
    Leicestershire
    BritishCompany Director12347730001

    ¿Tiene H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 16 ago 2006
    Entregado el 30 ago 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land on the north side of hawley road, the north east side of rugby road and land to the south of clarendon road, leicestershire t/no LT154468. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • West Register (Investments) Limited
    Transacciones
    • 30 ago 2006Registro de un cargo (395)
    Fixed and floating
    Creado el 07 may 2003
    Entregado el 07 may 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 07 may 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 may 2003
    Entregado el 09 may 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allan Graham, Richard Philpott and Jane Moriarty
    Transacciones
    • 09 may 2003Registro de un cargo (395)
    Equipment mortgage
    Creado el 24 ene 2001
    Entregado el 06 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the equipment as specified in the schedule to the M395 and all of its right title and interest in and to spare parts and replacements for and all modifications and additions to the equipment.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 06 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 23 dic 1999
    Entregado el 12 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge all items listed in the shedule to the form 395, any replacements or renewals thereof, all other plant belonging to the company, all plant which becomes the property of the company after the date of the supplemental debenture, the company's interest in any plant in its possession and all fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 12 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of guarantee and debenture
    Creado el 21 abr 1999
    Entregado el 05 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 05 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 03 abr 1998
    Entregado el 16 abr 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on north west of netherley road hinckley leicestershire t/n LT157787. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 abr 1998Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 06 ene 1997
    Entregado el 16 ene 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land and buildings on the north side of hawley road the north east side of rugby road and laying to the south of claredon road hinckley leicestershire t/n LT154468 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ene 1997Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 oct 1996
    Entregado el 15 nov 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 1996Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 30 ago 1984
    Entregado el 20 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,000,000
    Breve descripción
    Floating charge over all the undertaking of the company and its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital if any.
    Personas con derecho
    • H. Flude (Holdings) Limited
    Transacciones
    • 20 sept 1984Registro de una carga
    • 16 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene H. FLUDE & CO. (HINCKLEY) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 dic 2002Inicio de la administración
    07 jul 2005Administración dada por terminada
    Orden de administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Allan Watson Graham
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Profesional
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Jane Bronwen Moriarty
    St Nicholas House
    Park Row
    Nottingham
    Ng1 6fq
    Profesional
    St Nicholas House
    Park Row
    Nottingham
    Ng1 6fq
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Profesional
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    2
    FechaTipo
    21 mar 2003Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    03 nov 2010Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    Peat House
    LE1 6LP 1 Waterloo Way
    Leicester
    Profesional
    Kpmg Llp
    Peat House
    LE1 6LP 1 Waterloo Way
    Leicester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0