CONTROL EQUIPMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CONTROL EQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01769524 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CONTROL EQUIPMENT SERVICES LIMITED | 31 ene 1984 | 31 ene 1984 |
| LOTUSROAD LIMITED | 14 nov 1983 | 14 nov 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 05 feb 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Ayre como director el 31 ago 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Bowie como director el 31 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Bowie el 30 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Peter Schieser el 30 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anton Bernard Alphonsus como secretario el 10 mar 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 25 sept 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 26 sept 2014 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYRE, Mark | Director | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | England | British | 129877500001 | |||||
| SCHIESER, Peter | Director | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | Luxembourg | German | 179601330001 | |||||
| ALPHONSUS, Anton Bernard | Secretario | The Summit Hanworth Road TW16 5DB Sunbury-On-Thames Security House Middlesex | British | 158440940001 | ||||||
| BRADBURY, Trevor | Secretario | 16 Gingells Farm Road Charvil RG10 9DJ Reading Berkshire | British | 47884750002 | ||||||
| DEVEREUX, James William Robert | Secretario | 37 Broad Street CV37 6HN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 63979360001 | ||||||
| DIXON, Clive Sidney | Secretario | 159 Aston Cantlow Road Wilmcote CV37 9XW Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 75060001 | ||||||
| HARRISON, Colin Lancaster | Secretario | Wormald Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | British | 44394290002 | ||||||
| KEMMANN LANE, Peter James | Secretario | 62 Park Road SS0 7PQ Southend On Sea Essex | British | 105653330002 | ||||||
| NEALE, David | Secretario | Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport 9 United Kingdom | British | 121132860001 | ||||||
| OCHILTREE, Kim Lesley | Secretario | 25 Nesta Road IG8 9RG Woodford Green Essex | British | 80269530001 | ||||||
| BOGGESS, Jerry Reid | Director | 671 South Ocean Boulevard Boca Raton Florida 33432 Usa | American | 68774400001 | ||||||
| BOWIE, Andrew | Director | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | United Kingdom | British | 140054660001 | |||||
| BUCKLEY, John Clifford | Director | 5 Severn Close SK10 3DD Macclesfield Cheshire | Australian | 1436420001 | ||||||
| DEVEREUX, James William Robert | Director | 37 Broad Street CV37 6HN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 63979360001 | ||||||
| GATELEY, Christopher | Director | 29 Badger Way Hazlemere HP15 7LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 60152530001 | ||||||
| JENNINGS, Norman Anthony | Director | One B Newey Street DY1 2SB Dudley West Midlands | British | 54095120001 | ||||||
| JONES, James Brian | Director | 3 Talbot Street WS15 2EQ Rugeley Staffordshire | British | 57880370001 | ||||||
| LANT, David | Director | 39 Wyle Cop SY1 1XF Shrewsbury Salop | British | 19160690001 | ||||||
| LEONARD, Peter Charles | Director | Tyco Park Grimshaw Lane, Newton Heath M40 2WL Manchester | British | 119805430001 | ||||||
| LUDLOW, Grahame George Robert | Director | Compton House Oakfield Hawkhurst TN18 4JR Cranbrook Kent | British | 51059130001 | ||||||
| OLIVER, Raymond | Director | 39 Garth Road TN13 1RU Sevenoaks Kent | British | 61367290001 | ||||||
| STEAD, Terence Keith Parsons | Director | Derry Close 1 The Derry Ashton Keynes SN6 6PW Swindon | England | British | 62519500001 | |||||
| SUMMERFIELD, David | Director | 18 Knowle Wood Road Dorridge B93 8JJ Solihull West Midlands | British | 16677830001 | ||||||
| WALTERS, Kenneth John | Director | 69 Kiddemore Green Road Brewood ST19 9BQ Stafford Staffordshire | British | 19160680002 | ||||||
| WILLIAMS, John Stanley | Director | Norton Green House Norton Green Lane Knowle B93 8PJ Solihull West Midlands | British | 12946360001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorn Security Limited | 06 abr 2016 | The Summit Hanworth Road TW16 5DB Sunbury On Thames Security House Middlesex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CONTROL EQUIPMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creado el 06 sept 1995 Entregado el 07 sept 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over all book debts | Creado el 13 jun 1986 Entregado el 20 jun 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All book debts & other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 27 mar 1984 Entregado el 02 abr 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0