SHUKCO 333 LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHUKCO 333 LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01769573
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHUKCO 333 LTD?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SHUKCO 333 LTD?

    Dirección de la sede social
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHUKCO 333 LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SITA WASTECARE (LONDON) LIMITED02 nov 200002 nov 2000
    S.I.T.A. WASTECARE (LONDON) LIMITED26 may 200026 may 2000
    POLKACREST LIMITED14 nov 198314 nov 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHUKCO 333 LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SHUKCO 333 LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHUKCO 333 LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Christophe Andre Bernard Chapron el 01 sept 2015

    2 páginasCH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed sita wastecare (london) LIMITED\certificate issued on 14/07/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 jul 2015

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 03 jun 2015

    RES15

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 jul 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 03 jun 2015

    RES15

    Resoluciones

    Resolutions
    10 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jun 2015

    • Capital: GBP 146,202
    3 páginasSH01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 oct 2014

    Estado de capital el 13 oct 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 oct 2013

    Estado de capital el 04 oct 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Christophe Andre Bernard Chapron el 26 jun 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Christophe Andre Bernard Chapron el 30 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Joan Knight el 30 sept 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SHUKCO 333 LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KNIGHT, Joan
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British80543820001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500006
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Secretario
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    British3540250005
    MILES, Simon David
    3 Winchester Grove
    TN13 3BL Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    3 Winchester Grove
    TN13 3BL Sevenoaks
    Kent
    British1487680002
    SARGENT, David George
    Balla Struan
    Priory Close East Farleigh
    ME15 0EY Maidstone
    Kent
    Secretario
    Balla Struan
    Priory Close East Farleigh
    ME15 0EY Maidstone
    Kent
    British34029590002
    THORNE, Simon John
    Walnut Cottage Englemere Park
    Kings Ride
    SL5 8AE Ascot
    Berkshire
    Secretario
    Walnut Cottage Englemere Park
    Kings Ride
    SL5 8AE Ascot
    Berkshire
    British50927090001
    GOODFELLOW, Ian Frederick
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    Director
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritish28725450004
    GORDON, Marek Robert
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20420300002
    JACKSON, Paul Robert
    15 Willow Springs
    High Street, Cranfield
    MK43 0DS Bedford
    Bedfordshire
    Director
    15 Willow Springs
    High Street, Cranfield
    MK43 0DS Bedford
    Bedfordshire
    British66857000001
    MILES, David John
    7 Linden Gardens
    TN2 5QU Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    7 Linden Gardens
    TN2 5QU Tunbridge Wells
    Kent
    British1487700001
    MILES, Edwina Ann
    7 Linden Gardens
    TN2 5QU Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    7 Linden Gardens
    TN2 5QU Tunbridge Wells
    Kent
    British16343440001
    MILES, Jonathan
    Post Office Cottage
    Chiddingstone Causeway
    TN11 8JN Tonbridge
    Kent
    Director
    Post Office Cottage
    Chiddingstone Causeway
    TN11 8JN Tonbridge
    Kent
    British70324300001
    MILES, Simon David
    3 Winchester Grove
    TN13 3BL Sevenoaks
    Kent
    Director
    3 Winchester Grove
    TN13 3BL Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1487680002
    SARGENT, David George
    Balla Struan
    Priory Close East Farleigh
    ME15 0EY Maidstone
    Kent
    Director
    Balla Struan
    Priory Close East Farleigh
    ME15 0EY Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish34029590002
    SEARBY, Robert Anthony
    4 Davis Close
    SL7 1SY Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    4 Davis Close
    SL7 1SY Marlow
    Buckinghamshire
    British1737470005
    SEXTON, Ian Anthony
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33971310004
    THORNE, Simon John
    Walnut Cottage Englemere Park
    Kings Ride
    SL5 8AE Ascot
    Berkshire
    Director
    Walnut Cottage Englemere Park
    Kings Ride
    SL5 8AE Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish50927090001
    YOUNG, Nigel David
    The Elms
    Clubhouse Lane
    BS28 4JS Wedmore
    Somerset
    Director
    The Elms
    Clubhouse Lane
    BS28 4JS Wedmore
    Somerset
    British75983970001

    ¿Tiene SHUKCO 333 LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 24 mar 1999
    Entregado el 30 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transacciones
    • 30 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 12 feb 1998
    Entregado el 14 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge: 1 x microwave medical waste disinfection system serial no. 9603A-045.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 14 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Creado el 23 dic 1997
    Entregado el 30 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under an invoice discounting agreement
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge alldebts the subject of an invoice discounting agreement by way of floating charge such of the moneys which thecompany masy receive.
    Personas con derecho
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transacciones
    • 30 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General charge
    Creado el 28 ago 1997
    Entregado el 29 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company' assets of whatsoever nature and wheresoever situate both present and future (including uncalled capital).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 28 ago 1997
    Entregado el 29 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A first fixed charge over the goods listed in the attached schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 28 ago 1997
    Entregado el 29 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal sum of £230,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    1 x microwave medical waste disinfection system serial no: 9603A-045.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 29 dic 1994
    Entregado el 03 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 nov 1985
    Entregado el 13 dic 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Transport yard, borough green road, wrotham, kent. Title no k 4786869.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 13 dic 1985Registro de una carga
    • 18 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0